PINNACLE CELLULAR LIMITED

PINNACLE CELLULAR LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPINNACLE CELLULAR LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC127133
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Dirección de la sede social
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2023

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023

    5 páginasAA

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Modification des détails de Pinnacle Cellular Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 jul 2023

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ United Kingdom a 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ el 04 jul 2023

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Janine Butler como director el 23 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Nigel Evans como director el 23 feb 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Janine Butler como director el 23 feb 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    4 páginasAA

    legacy

    256 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Domicilio social registrado cambiado de Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG a Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ el 14 may 2019

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Andrew Michael Yorston como director el 02 abr 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Michael Anthony Henry Olivier como director el 02 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diane Josephine Mcintyre como director el 16 mar 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro2357692
    75473330004
    OLIVIER, Michael Anthony Henry
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector257268230001
    YORSTON, Andrew Michael
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector257275320001
    COULL, Gillian Margaret
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Secretario
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British30641050001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Secretario
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    BritishSalesman76740000001
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Secretario
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Secretario
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secretario
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secretario designado
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WHEELER, David
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    Secretario
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    British102737470001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Director
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritishManaging Dir Scot Telecom111131550001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Director
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    BritishDirector123612980001
    BARR, Duncan David Whyte
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Director
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    BritishSales Executive37411850001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Director
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    BUTLER, Janine
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector277534960001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Director
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    BritishCompany Director76740000001
    EVANS, David Nigel
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Director
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    GOW, John Warrender
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    Director
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    BritishCompany Director55207220001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Director
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritishDirector50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Director
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    BritishDirector33951180005
    HERROD, Harry Alan
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    Director
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    BritishDirector93998280001
    HILLS, Kenneth Cumming
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector65152940001
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Director
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishCompany Director74872510003
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Director
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    MCNEILL, Ronald
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    Director
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    BritishCorporate Advisor205550003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc123629
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PINNACLE CELLULAR LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 27 feb 1996
    Entregado el 04 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 mar 1996Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 nov 1995
    Entregado el 29 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises, 27 union street, dundee.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 nov 1995Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 nov 1995
    Entregado el 29 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises, 35 and 37A high street, ayr.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 nov 1995Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 abr 1994
    Entregado el 26 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop 12 leven street, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 abr 1994Registro de un cargo (410)
    • 03 nov 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 06 abr 1991
    Entregado el 19 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1991Registro de una carga
    • 11 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0