PINNACLE CELLULAR LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PINNACLE CELLULAR LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC127133 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PINNACLE CELLULAR LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PINNACLE CELLULAR LIMITED?
Dirección de la sede social | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PINNACLE CELLULAR LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PINNACLE CELLULAR LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 5 páginas | AA | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Modification des détails de Pinnacle Cellular Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 jul 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ United Kingdom a 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ el 04 jul 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Janine Butler como director el 23 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 5 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de David Nigel Evans como director el 23 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Janine Butler como director el 23 feb 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 4 páginas | AA | ||
legacy | 256 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG a Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ el 14 may 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew Michael Yorston como director el 02 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Anthony Henry Olivier como director el 02 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Diane Josephine Mcintyre como director el 16 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PINNACLE CELLULAR LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
OLIVIER, Michael Anthony Henry | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 257268230001 | ||||||||
YORSTON, Andrew Michael | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 257275320001 | ||||||||
COULL, Gillian Margaret | Secretario | 62 Alloway Crescent FK4 1EZ Bonnybridge Stirlingshire | British | 30641050001 | ||||||||||
COULL, Graham | Secretario | 3 Coney Park Kings Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | Salesman | 76740000001 | |||||||||
DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Secretario | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||||||
EMETULU, Lola | Secretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
JEFFERSON, Karen | Secretario | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||||||
MACLEOD, David | Secretario | 12 Glebe Road Newton Mearns G77 6DU Glasgow | British | 32696310001 | ||||||||||
REID, Brian | Secretario designado | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||
SCOTT, Stephen Roy | Secretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||||||
WHEELER, David | Secretario | Carn Mairg Wallacestone Brae FK2 0DH Brightons Stirlingshire | British | 102737470001 | ||||||||||
ALLAN, William | Director | Shernfold Meadows Wadhurst Road TN3 9EH Frant East Sussex | Uk | British | Managing Dir Scot Telecom | 111131550001 | ||||||||
ALLEN, Christian Philip Quentin | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | British | Director | 123612980001 | |||||||||
BARR, Duncan David Whyte | Director | 95 Wheatlands Avenue FK4 1PJ Bonnybridge Stirlingshire | British | Sales Executive | 37411850001 | |||||||||
BREWER, Stephen | Director | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | Company Director | 79186090002 | |||||||||
BROCKLEHURST, Nigel | Director | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | Director | 83126790001 | |||||||||
BUTLER, Janine | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House United Kingdom | England | British | Director | 277534960001 | ||||||||
CHESWORTH, Paul | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 99525280001 | |||||||||
COULL, Graham | Director | 3 Coney Park Kings Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | Company Director | 76740000001 | |||||||||
EVANS, David Nigel | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 134975040001 | ||||||||
EVANS, Mark | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Chief Financial Officer | 127017870001 | |||||||||
FINCH, Joanne Sarah | Director | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | Senior Finance Manager | 158146620001 | ||||||||
GOW, John Warrender | Director | 32 Cammo Gardens Barnton EH4 8EQ Edinburgh | British | Company Director | 55207220001 | |||||||||
GRAY, Ian | Director | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | Director | 50246030004 | ||||||||
HALFORD, Andrew Nigel | Director | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | Director | 33951180005 | |||||||||
HERROD, Harry Alan | Director | Dakar, 40 Camelon Road FK1 5SH Falkirk | British | Director | 93998280001 | |||||||||
HILLS, Kenneth Cumming | Director | 49 Spottiswoode Street EH9 1DQ Edinburgh Midlothian | British | Director | 65152940001 | |||||||||
KEY, Matthew David | Director | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Director | 62981720001 | |||||||||
LANGSTON, Edward | Director | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | Director | 24471140001 | ||||||||
LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
MATTHEWS, Roderick Alfred | Director | Aros House Rhu G84 8NJ Helensburgh Dunbartonshire | British | Company Director | 74872510003 | |||||||||
MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Director | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | Company Director | 173703620001 | ||||||||
MCNEILL, Ronald | Director | 4/6 New Bells Court Maritime Street EH6 6RY Edinburgh | British | Corporate Advisor | 205550003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PINNACLE CELLULAR LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle Cellular Group Limited | 06 abr 2016 | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene PINNACLE CELLULAR LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Bond & floating charge | Creado el 27 feb 1996 Entregado el 04 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 23 nov 1995 Entregado el 29 nov 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop premises, 27 union street, dundee. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 23 nov 1995 Entregado el 29 nov 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop premises, 35 and 37A high street, ayr. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 14 abr 1994 Entregado el 26 abr 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop 12 leven street, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Bond & floating charge | Creado el 06 abr 1991 Entregado el 19 abr 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0