INITIATIVE SOFTWARE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INITIATIVE SOFTWARE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC127774 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COMLAW NO. 238 LIMITED | 05 oct 1990 | 05 oct 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 08 ago 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 jun 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 jun 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 jun 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Donald Gilmour Wilson como director el 21 mar 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Douglas Mcloughlan como director el 30 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Clark como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 9 Charlotte Square Edinburgh Midlothian EH2 4DR el 23 dic 2010 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 oct 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 6 páginas | MG01s | ||||||||||
Nombramiento de Michael Scott Mcgill como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Douglas Mcloughlan el 08 ene 2010 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario David William Murray Horne el 12 nov 2009 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director James Donald Gilmour Wilson el 16 nov 2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INITIATIVE SOFTWARE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORNE, David William Murray | Secretario | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | 131680300001 | ||||||
| MCGILL, Michael Scott | Director | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British | 99070570001 | |||||
| BRUCE, Graeme Murray | Secretario designado | Madeleine Smith House 6/7 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | British | 900002440001 | ||||||
| CALDWELL, John Stewart | Secretario | 22 Jedburgh Drive PA2 9JJ Paisley Renfrewshire | British | 1320640001 | ||||||
| MARSHALL, David | Secretario | 5 Kelvin Crescent Bearsden G61 1BT Glasgow | British | 79453940001 | ||||||
| MCLOUGHLAN, Douglas | Secretario | 3 Carrongrange Gardens FK5 3DU Larbert | British | 48981460002 | ||||||
| BEATTIE, Kenneth George | Director | 35 Camphill Avenue G41 3AX Langside Glasgow | United Kingdom | British | 108957650001 | |||||
| BRUCE, Graeme Murray | Director designado | Madeleine Smith House 6/7 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | British | 900002440001 | ||||||
| CALDWELL, John Stewart | Director | 22 Jedburgh Drive PA2 9JJ Paisley Renfrewshire | Scotland | British | 1320640001 | |||||
| CLARK, Kevin Peter | Director | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British | 70888620001 | |||||
| GALBRAITH, Eric Roger | Director designado | Madeleine Smith House 6/7 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | British | 900002450001 | ||||||
| MARSHALL, David | Director | 5 Kelvin Crescent Bearsden G61 1BT Glasgow | United Kingdom | British | 79453940001 | |||||
| MCLOUGHLAN, Douglas | Director | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British | 165092070001 | |||||
| NEESON, Paul Gerard | Director | Duncrag Bonhill Road G82 2DY Dumbarton | Scotland | British | 54148210001 | |||||
| POWLEY, Moira | Director | 52 Thames Street TW16 6AF Lower Sunbury Middlesex | British | 53719440001 | ||||||
| SMITH, Alistair George | Director | 2 Ormiston Place Lawthorn Irvine | British | 1320660002 | ||||||
| THORBURN, Andrew Scott | Director | 20 Lennox Street Lane EH4 1PZ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 840430001 | |||||
| WAGA, John | Director | 2 Maple Grove Fixby HD2 2FG Huddersfield | British | 54999500001 | ||||||
| WALLACE, David Gordon | Director | Lethington Road G46 6TB Giffnock 14 East Renfrewshire | Scotland | British | 140806790001 | |||||
| WILSON, James Donald Gilmour | Director | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British | 69298770001 | |||||
| WYATT, Edward Jeremy | Director | Kirkland Coach House Bridgend KA24 4DA Dalry Ayrshire | British | 1254100001 |
¿Tiene INITIATIVE SOFTWARE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 20 abr 2010 Entregado el 04 may 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 dic 2008 Entregado el 17 dic 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 07 dic 2001 Entregado el 11 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 06 dic 2001 Entregado el 21 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 06 dic 2001 Entregado el 20 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 06 dic 2001 Entregado el 20 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 24 ago 2000 Entregado el 31 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 20 ago 1999 Entregado el 26 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 04 jun 1996 Entregado el 07 jun 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0