WOODEND HOLDINGS LIMITED

WOODEND HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWOODEND HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC128335
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Edinburgh House
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PALOPLAN LIMITED08 nov 199008 nov 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG a Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ el 15 may 2019

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Andrew Michael Yorston como director el 02 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diane Josephine Mcintyre como director el 16 mar 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 abr 2016

    Estado de capital el 25 abr 2016

    • Capital: GBP 162,010
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 mar 2015

    Estado de capital el 07 mar 2015

    • Capital: GBP 162,010
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Joanne Sarah Finch como director el 26 sept 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 14 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 mar 2014

    Estado de capital el 14 mar 2014

    • Capital: GBP 162,010
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    6 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Lochside House 7 Lochside Avenue Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9DJ Scotland* el 18 sept 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr David Nigel Evans como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martin Purkess como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 14 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Diane Mcintyre como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Schäfer como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario corporativo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector134975040001
    YORSTON, Andrew Michael
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector257275320001
    BAIRD, Brian Alexander
    4 Cheviot Drive
    G77 5AS Glasgow
    Secretario
    4 Cheviot Drive
    G77 5AS Glasgow
    British95529070001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secretario
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    MCINTYRE, Colin
    473 Clarkston Road
    G44 3LW Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    473 Clarkston Road
    G44 3LW Glasgow
    Lanarkshire
    British732300001
    PRENTICE, Edward Duncan
    72 Lymekilns Road
    East Kilbride
    G74 4TU Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    72 Lymekilns Road
    East Kilbride
    G74 4TU Glasgow
    Lanarkshire
    British72432810001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Secretario corporativo
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    38051430002
    QUILL SERVE LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secretario designado corporativo
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    900000590001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Director
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritishManaging Director,Scot.Telecom111131550001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Director
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    BritishDirector123612980001
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Director
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    FORD, John Joseph
    30 Gildale
    Werrington
    PE4 6QY Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    30 Gildale
    Werrington
    PE4 6QY Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishDirector78094110001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Director
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritishDirector50246030004
    GROSSART, Sally
    27 Howe Street
    EH3 6TF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    27 Howe Street
    EH3 6TF Edinburgh
    Midlothian
    BritishCorporate Financial Adviser59761370001
    HADDEN, Mervyn Alexander
    Chantry Cottage
    The Warren
    KT24 5RH East Horsley
    Surrey
    Director
    Chantry Cottage
    The Warren
    KT24 5RH East Horsley
    Surrey
    British94655490001
    HADDOW, Neil Scott
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    Director
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    BritishFinance Dir Scottish Telecom53774190001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Director
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    BritishDirector33951180005
    HILLS, Kenneth Cumming
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector65152940001
    HOULDSWORTH, June
    Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road
    High Blantyre
    G72 9UY Glasgow
    Director
    Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road
    High Blantyre
    G72 9UY Glasgow
    United KingdomBritishDirector1376720001
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector62981720001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishChief Executive74872510003
    MCALOON, William Gerard
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    Director
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    BritishFinance Director108756350001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Director
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    MCLEAN, Gregory Joseph
    3 Princes Terrace
    Dowanhill
    G12 9JW Glasgow
    Director
    3 Princes Terrace
    Dowanhill
    G12 9JW Glasgow
    AmericanFinance Director33612180002
    NOWAK, Thomas, Dr
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Director
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PRENTICE, Edward Duncan
    72 Lymekilns Road
    East Kilbride
    G74 4TU Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    72 Lymekilns Road
    East Kilbride
    G74 4TU Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCa72432810001
    PURKESS, Martin John
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Director
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritishDirector139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director87149560001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WOODEND HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    06 abr 2016
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc140935
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WOODEND HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 05 abr 1991
    Entregado el 15 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 abr 1991Registro de una carga
    • 25 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0