CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC128650 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
- Otras instalaciones de construcción (43290) / Construcción
¿Dónde se encuentra CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 24 Blythswood Square G2 4BG Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WETPARK LIMITED | 22 nov 1990 | 22 nov 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en CVL | 15 páginas | LIQ14(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH Scotland a 24 Blythswood Square Glasgow G2 4BG el 21 mar 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland a C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive Leith Edinburgh EH6 6JH | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Millar Bryce Bonnington Bond 2 Anderson Place Leith Edinburgh EH6 5NP a C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH el 24 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cessation de Michael John Dyson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jun 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland a Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael John Dyson el 13 ago 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 95 Westburn Drive Cambuslang Glasgow G72 7NA Scotland a Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael John Dyson el 13 ago 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andy Dobing como director el 24 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael John Dyson como director el 13 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alastair Richard Gamage como director el 16 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andy Dobing como director el 11 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Mel Butler como director el 29 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYSON, Michael John | Director | Thorncliffe Park Estate, Newton Chambers Road Chapeltown S35 2PH Sheffield 5 Park Square England | England | British | 73151180001 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Secretario | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
| REID, Brian | Secretario designado | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||
| SMITH, Linda Helen | Secretario | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | British | 313940002 | ||||||
| SMITH, Ronnie Mckenzie | Secretario | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | British | 313950002 | ||||||
| BUTLER, Mel | Director | Century Way Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 3310 United Kingdom | United Kingdom | British | 187274630001 | |||||
| DOBING, Andrew Paul | Director | Bonnington Bond 2 Anderson Place EH6 5NP Leith C/O Millar Bryce Edinburgh | England | British | 202646660001 | |||||
| DONALD, Neil | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 195321250001 | |||||
| EATOCK, Matthew Joseph | Director | Langsett Road S6 2LW Sheffield Hillsborough Works South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 187184300001 | |||||
| EBSWORTH, Ronald Edwin | Director | 6 Adair Place FK13 6RS Tillicoultry Clackmannanshire | British | 75543300002 | ||||||
| FLEMING, Adam | Director | 5 Langhill Drive Balloch G68 9AP Cumbernauld Lanarkshire | British | 109188480001 | ||||||
| FOTHERINGHAM, Colin George Ewing | Director | Pond View Drain Lane Holme On Spalding Moor YO43 4DQ York East Yorkshire | United Kingdom | British | 82642480001 | |||||
| GAMAGE, Alastair Richard | Director | Century Way Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 3310 United Kingdom | United Kingdom | British | 124982420001 | |||||
| GREENAWAY, Andrew Paul | Director | Langsett Road S6 2LW Sheffield Hillsborough Works South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 120869420001 | |||||
| HUDSON, Jonathan Adrian | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 27743810004 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Director | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| SMITH, Linda Helen | Director | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | Scotland | British | 313940002 | |||||
| SMITH, Ronnie Mckenzie | Director | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | Scotland | British | 313950002 | |||||
| WAGHORN, Iain Lawrence | Director | 98 Forfar Road DD4 7BG Dundee | Scotland | British | 40141580001 | |||||
| WAUGH, Joanne | Director designado | 27 Castle Street EH2 3DN Edinburgh | British | 900000070001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Michael John Dyson | 06 abr 2016 | Thorncliffe Park, Chapeltown S35 2PH Sheffield Unit 5 Park Square England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Miller Pattison Ltd | 06 abr 2016 | Thorncliffe Park, Chapeltown S35 2PH Sheffield Unit 5 Park Square England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 21 abr 1998 Entregado el 27 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 dic 1992 Entregado el 05 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0