PUB.COM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PUB.COM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC129094 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | Sí |
¿Cuál es el propósito de PUB.COM LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra PUB.COM LIMITED?
| Dirección de la sede social | SC129094 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 24238 EH7 9HR Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PUB.COM LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EAGLE TAVERNS LIMITED | 10 sept 1991 | 10 sept 1991 |
| FORECO LIMITED | 20 dic 1990 | 20 dic 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PUB.COM LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 15 ago 2021 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PUB.COM LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 feb 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PUB.COM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Adresse du siège social modifiée à PO Box 24238, Sc129094 - Companies House Default Address, Edinburgh, EH7 9HR le 22 jul 2025 | 1 páginas | RP05 | ||||||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 8 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 09 mar 2023
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 8 páginas | MA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Derek Anthony Howell como director el 01 feb 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 01 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 01 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 22 ago 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 15 ago 2021 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 206 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 16 ago 2020 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 24 ago 2020 au 11 ago 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PUB.COM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWELL, Derek Anthony | Director | Chamberlain Square B3 3AX Birmingham One England | United Kingdom | British | 299032280001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191628150001 | |||||||
| BURNETT, Andrew Alan | Secretario | 38 Templeland Road EH12 8RP Edinburgh Lothian | British | 41431820001 | ||||||
| CROSS, Anthony | Secretario | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| DEEGAN, Jayne | Secretario | 5 Hardstruggle Row Eskdaleside YO22 5ET Sleights North Yorkshire | British | 94870790001 | ||||||
| HAMILTON, William Burt | Secretario | Douglas House 58c Allanfauld Road Cumbernauld Glasgow | British | 1054590001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488580001 | |||||||
| MILLER, Nicola Jane | Secretario | 27 Hillston Close TS26 0PE Hartlepool | British | 95390370001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| SILLARS, Steven | Secretario | 36 Nevis Road PA4 0PD Renfrew Renfrewshire | British | 53346570001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161694520001 | |||||||
| MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Scotland | 53781850001 | |||||||
| ARMSTRONG, Michael John | Director | Hunters Gate 56 Palace Road HG4 1HA Ripon North Yorkshire | British | 16410290001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BRANNAN, Robert | Director | 13 Carlingnose Way North Queensferry KY11 1EU Inverkeithing Fife | United Kingdom | British | 64147580002 | |||||
| BURNETT, Andrew Alan | Director | 38 Templeland Road EH12 8RP Edinburgh Lothian | Scotland | British | 41431820001 | |||||
| CHALMERS, Judith Isobel | Director | Flat 2, 31 Silverwells Crescent Bothwell G71 8DP Strathclyde | British | 71716940002 | ||||||
| CRAIG, Frederick John Robert | Director | Gateside KY14 7SX Cupar Freeland Fife United Kingdom | Scotland | British | 133316040001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GRIER, Ian Birrell | Director | 5 Forrest Drive G61 4SJ Bearsden | Scotland | British | 87612170001 | |||||
| GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 55975990001 | |||||
| GUNDRY, Richard | Director | Holgate Farm 29 The Street Bunwell NR16 1NA Norwich Norfolk | British | 107010490001 | ||||||
| HAMILTON, William Burt | Director | Douglas House 58c Allanfauld Road Cumbernauld Glasgow | British | 1054590001 | ||||||
| JENKINS, Stuart Nicol | Director | Parkview, 7 Arden Drive Giffnock G46 7AF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 116623260001 | |||||
| LAING, Peter John | Director | 56/1 Timberbush Leith EH6 6QH Edinburgh Midlothian | British | 82725660001 | ||||||
| MACKINNON, David Donaldson | Director | 15 Victoria Road PA19 1LD Gourock | Scotland | British | 116526660001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Director | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MCNULTY, John Vincent | Director | 7 Romney Avenue G44 5AW Glasgow Lanarkshire | British | 1103140001 | ||||||
| MORRISON, William | Director | 15 Nursery Grove PA13 4NH Kilmacolm Renfrewshire | British | 53297620001 | ||||||
| O'CALLAGHAN, Francis | Director | 21 Hamilton Avenue Pollokshields G41 4JG Glasgow | Scotland | British | 557570001 | |||||
| PRESTON, Neil David | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SANDS, John Robert | Director | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PUB.COM LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punch Taverns (Pmt) Limited | 06 abr 2016 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PUB.COM LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0