DETAILAGENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DETAILAGENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC129563 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DETAILAGENT LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DETAILAGENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DETAILAGENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DETAILAGENT LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jul 2025 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DETAILAGENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Dempsey como secretario el 04 jul 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nizar Bahadurali Pabani como secretario el 04 jul 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Lynott como director el 30 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||||||
Notification de Kwik-Fit Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mar 2025 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Kwik-Fit Euro Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mar 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Estado de capital el 26 mar 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 26 mar 2025
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 26 mar 2025
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Kwik Fit Euro Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DETAILAGENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMPSEY, Paul | Secretario | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | 337999950001 | |||||||
| FUKUDA, Takeshi | Director | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 247034300001 | |||||
| BLACK, Lysanne Jane Warren | Secretario | 2a Carlton Street EH4 1NJ Edinburgh Midlothian Scotland | British | 46707740001 | ||||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Secretario | 25 Belford Gardens EH4 3EP Edinburgh Midlothian | British | 34800860001 | ||||||
| ELLIS, Ian Vincent | Secretario | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | British | 162126350001 | ||||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Secretario | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | British | 99111340001 | ||||||
| HUNTER, John Stewart | Secretario | 27 Queens Crescent EH9 2BA Edinburgh | British | 1127070001 | ||||||
| MACRAE, Alistair Ian | Secretario | 15 Connaught Place EH6 4RQ Edinburgh Midlothian | British | 1361440002 | ||||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Secretario | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MORRISON, Scott | Secretario | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| PABANI, Nizar Bahadurali | Secretario | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | 278088870001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BARKLEY, John | Director | 10 Willow Tree Place The Beeches EH14 5AZ Balerno Edinburgh, Midlothian | British | 18955940002 | ||||||
| BISSETT, Graeme | Director | 123 Saint Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | 79800380001 | ||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Director | 6 Devonshire Terrace G12 0XF Glasgow | British | 34265760001 | ||||||
| FRASER, Ian Ellis | Director | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||
| HARADA, Yasuyuki | Director | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 247034000001 | |||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Director | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 99111340001 | |||||
| HOUSTON, John Mclellan | Director | The Rock 3 Douglas Avenue PA14 6PE Langbank | British | 712840002 | ||||||
| HUTHERSALL, Robert | Director | 56 Pentland Drive EH10 6PX Edinburgh | British | 3204110005 | ||||||
| LANDAU, Ervin | Director | 78 Harley House Marylebone Road NW1 5HN London | United Kingdom | British | 91134410001 | |||||
| LESLIE, Colin David | Director | 12 Viewbank View EH19 2HU Bonnyrigg Midlothian | British | 1358070001 | ||||||
| LESLIE, Colin David | Director | 12 Viewbank View EH19 2HU Bonnyrigg Midlothian | British | 1358070001 | ||||||
| LYNOTT, Mark | Director | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | British | 186944700003 | |||||
| MACINTYRE, Iain | Director | Holly Lodge 33 Kaimes Road EH12 6JS Corstorphine Edinburgh | British | 35375540002 | ||||||
| MASTERTON, Gavin George | Director | 6 Coldingham Place Garvock Hill KY12 7XS Dunfermline Fife | United Kingdom | British | 663070001 | |||||
| MCGILL, Colin Scott | Director | 10 Wester Coates Avenue EH12 5LS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 663080001 | |||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Director | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Director | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MURAI, Kenji | Director | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 95702340002 | |||||
| OGURA, Kazushi | Director | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | Japanese | 150485750001 | |||||
| OWENS, Stanley Hart | Director | 15b Ewerland Barnton EH4 6DH Edinburgh | American | 75755850002 | ||||||
| PARKER, James Robert | Director | 29 Netherton Road TW1 1LZ Twickenham Middlesex | England | British | 112964470001 | |||||
| PARKER, Timothy Charles | Director | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 126476060001 | |||||
| SLADE, Mark Richard | Director | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | England | British | 185568260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DETAILAGENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwik-Fit Holdings Limited | 27 mar 2025 | Avenue One SG6 2HU Letchworth Garden City Etel House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Shinjiro Tanaka | 01 mar 2019 | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Japanese País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Yasuyuki Harada | 01 abr 2018 | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Japanese País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Kwik-Fit Euro Limited | 06 abr 2016 | Avenue One SG6 2HU Letchworth Garden City Etel House Hertfordshire England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Kenji Murai | 06 abr 2016 | 216 East Main Street Broxburn EH52 5AS West Lothian | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Japanese País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0