WASELEY (CVS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WASELEY (CVS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC135998 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WASELEY (CVS) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra WASELEY (CVS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Suite D, Pavilion 7 Kingshill Park Venture Drive, Arnhall Business Park AB32 6FL Westhill Aberdeenshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WASELEY (CVS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CASTLE VIEW SERVICES LIMITED | 30 may 1996 | 30 may 1996 |
| CCG SERVICES LIMITED | 24 abr 1996 | 24 abr 1996 |
| CASTLE VIEW SERVICES LIMITED | 16 abr 1996 | 16 abr 1996 |
| CCG (SERVICES) LIMITED | 16 jul 1992 | 16 jul 1992 |
| COMMERCIAL CATERING GROUP (1991) LIMITED | 20 feb 1992 | 20 feb 1992 |
| DEMOHURRY LIMITED | 16 ene 1992 | 16 ene 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WASELEY (CVS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WASELEY (CVS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WASELEY (CVS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2024 | 3 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Gareth Jonathan Sharpe el 30 abr 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robin Ronald Mills el 20 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Gareth Jonathan Sharpe como director el 02 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Robin Ronald Mills como director el 31 jul 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Jane Sergeant como director el 31 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Kate Dunham como director el 31 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Sarah Jane Sergeant como director el 01 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Alison Jane Henriksen como director el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Kate Dunham como director el 01 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Waseley (Cvi) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 sept 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
¿Quiénes son los directivos de WASELEY (CVS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Guildford Street KT16 9BQ Chertsey Compass House Surrey | 136459060001 | |||||||
| LEA, Jodi | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 250369010001 | |||||
| MILLS, Robin Ronald | Director | Kingshill Park Venture Drive, Arnhall Business Park AB32 6FL Westhill Suite D, Pavilion 7 Aberdeenshire United Kingdom | England | British | 264890000002 | |||||
| SHARPE, Gareth Jonathan | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | England | British | 289083810002 | |||||
| MASON, Timothy Charles | Secretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| MASON, Timothy Charles | Secretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| PEGG, Jane | Secretario | Brickyard Cottage Rushock WR9 0NS Droitwich Worcestershire | British | 111345130001 | ||||||
| WALKER, James Alan Fairley | Secretario | Priddeons Hadley Common EN5 5QE Barnet Hertfordshire | British | 7945280002 | ||||||
| WORKMAN, Hugh John | Secretario | 11 Lochend Crescent Bearsden G61 1EA Glasgow Lanarkshire | British | 40633560001 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ABSALOM, Peter Lyon | Director | 51 Finchdean Road PO9 6DA Rowlands Castle Hampshire | British | 28594430001 | ||||||
| BELL, Francis Joseph | Director | 7x Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | United Kingdom | British | 230100002 | |||||
| BRIGGS, Trevor Holden | Director | Greystone 35 Kent Road HG1 2LJ Harrogate North Yorkshire | England | British | 71533050002 | |||||
| COPLAND, Barbara | Director | 6 Bayhurst Drive HA6 3SA Northwood Middlesex | British | 46002690002 | ||||||
| DAVENPORT, Donald Andrew | Director | Ramsbury House 23 Badgers Hill Wentworth GU25 4SA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 13178710003 | |||||
| DAVIDSON, Elizabeth Anne | Director | 604 Clarkston Road G44 3SQ Glasgow Scotland | British | 59691570001 | ||||||
| DOWNING, Roger Arthur | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | England | British | 164972410001 | |||||
| DUNHAM, Kate | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 255875080001 | |||||
| GALVIN, Paul Anthony | Director | WR6 6LL Little Witley Landscape Worcestershire United Kingdom | England | British | 159125490001 | |||||
| GALVIN, Paul Anthony | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 159125490002 | |||||
| GOW, Ian, Professor | Director | 1 Victoria Place FK8 2QX Stirling Stirlingshire | British | 60474520001 | ||||||
| HAY, James Robert Colqhoun | Director | 53 Durnsford Avenue GU13 9TB Fleet Hampshire | British | 29441130001 | ||||||
| HAY, Kenneth John | Director | 4 Ferry Orchard Cambuskenneth Stirlingshire | British | 261680001 | ||||||
| HENRIKSEN, Alison Jane | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 256400460001 | |||||
| KELLY, Peter Dennis | Director | Homelands Dean Street East Farelight ME13 UPT Maidstone | British | 28594560001 | ||||||
| MAGUIRE, Peter John | Director | 75 High Street Hampton In Arden B92 0AE Solihull | United Kingdom | British | 127332260001 | |||||
| MASON, Timothy Charles | Director | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 12314170002 | |||||
| MCNALLY, Eric Alexander | Director | Hunterhill Cottage PA2 6SU Paisley | British | 718810001 | ||||||
| MCNAUGHT, David Arthur | Director | 53 Lynnhurst G71 6SA Uddingston | British | 78055790001 | ||||||
| MEE, Andy Edward | Director | Loughglynn Bunstrux HP23 4HT Tring Herts | England | British | 177086470001 | |||||
| MORTIMER, David Grant | Director | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||
| OWEN, Michael James | Director | 13 Carden Place Aberdeen AB10 1UR Aberdeenshire | United Kingdom | British | 246105820001 | |||||
| QUEEN, Michael Joseph | Director | 20 Alexander Drive Bridge Of Allan FK9 4QB Stirling Stirlingshire | British | 260270001 | ||||||
| SARSON, Ian James | Director | Oak Tree Farmhouse Upper Wyke SP11 6EA St Mary Bourne | England | British | 110831940001 | |||||
| SERGEANT, Sarah Jane | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British | 250097760001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WASELEY (CVS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waseley (Cvi) Limited | 06 abr 2016 | Kingshill Park Venture Drive, Arnhall Business Park AB32 6FL Westhill Suite D, Pavilion 7 Aberdeenshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0