IBIS NO. 3 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | IBIS NO. 3 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC138897 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IBIS NO. 3 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra IBIS NO. 3 LIMITED?
Dirección de la sede social | Menzies Glasgow Hotel 27 Washington Street G3 8AZ Glasgow United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IBIS NO. 3 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MENZIES HOTELS (PROPERTY) LIMITED | 22 dic 1999 | 22 dic 1999 |
WEST REGISTER (HOTELS) LIMITED | 07 oct 1992 | 07 oct 1992 |
DUNWILCO (329) LIMITED | 17 jun 1992 | 17 jun 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IBIS NO. 3 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ene 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IBIS NO. 3 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert William Grainger como secretario el 31 ene 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed menzies hotels (property) LIMITED\certificate issued on 10/08/11 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 jun 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 jun 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Timothy John Penter el 13 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Robert William Grainger el 13 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joseph O'callaghan el 13 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 ene 2008 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 ene 2007 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 8 páginas | 363s |
¿Quiénes son los directivos de IBIS NO. 3 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'CALLAGHAN, Joseph | Secretario | 27 Washington Street G3 8AZ Glasgow Menzies Glasgow Hotel United Kingdom | British | 110216340001 | ||||||
PENTER, Timothy John | Director | 27 Washington Street G3 8AZ Glasgow Menzies Glasgow Hotel United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Hotelier | 98199970003 | ||||
FROST, Peter | Secretario | Wild Orchard Cottage 6 Chapel Lane Gaddesby LE7 4WB Leicester Leicestershire | British | 6428530001 | ||||||
GRAINGER, Robert William | Secretario | 27 Washington Street G3 8AZ Glasgow Menzies Glasgow Hotel United Kingdom | Other | 110421460001 | ||||||
MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||
MILLS, Alan Ewing | Secretario | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||
O'MALLEY, John Joseph | Secretario | 5 Marsh Lane B91 2PG Sollihul West Midlands | British | Company Director | 49893480001 | |||||
PENTER, Timothy John | Secretario | 14 Starflower Way Mickleover DE3 0BS Derby Derbyshire | British | 98199970002 | ||||||
D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
BEATTIE, Robert Henry | Director | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Bank Official | 27224590001 | ||||
BEATTIE, Robert Henry | Director | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Bank Official | 27224590001 | ||||
CARRARO, Philip Andrew | Director | 70 Onslow Gardens SW7 3QD London | United States Citizen | Banker | 64702980001 | |||||
CARTLEDGE, David Edmund | Director | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | Bank Official | 38897330001 | |||||
CHRISPIN, Simon Jonathan | Director | 41 Claygate Avenue AL5 2HE Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 62029940002 | ||||
COUTTS, Maureen Sheila | Director designado | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | British | 900004630001 | ||||||
ELTON, James Robert | Director | 27 Elsie Road SE22 8DX London | United Kingdom | British | Director | 55689440001 | ||||
FOSTER, Kennedy Campbell | Director | 4 Deacons Court EH49 6BT Linlithgow West Lothian | British | Bank Official | 70070530001 | |||||
MCLEAN, Miller Roy | Director | 3 Bonaly Crescent EH13 0EN Edinburgh | British | Bank Official | 83720001 | |||||
MENZIES, Robert Nicholas | Director | Mooresfold Elton Road, Winster DE4 2DH Matlock Derbyshire | British | Hotelier | 141639900001 | |||||
MILLER, John Thomas Henry | Director | 49 Barnton Park Avenue EH4 6HD Edinburgh Midlothian | British | Bank Official | 802080001 | |||||
SACH, Derek Stephen | Director | Hattingley House Hattingley Road, Medstead GU34 5NQ Alton Hampshire | United Kingdom | British | Banker | 646390004 | ||||
SACH, Derek Stephen | Director | Warren Lodge 32 Leigh Hill Road KT11 2HZ Cobham Surrey | British | Banker | 646390001 | |||||
SHEAVILLS, Ernest Michael | Director | Coombe House, 8 Westgarth Avenue Colinton EH13 0BD Edinburgh | British | Bank Official | 34817880001 | |||||
SPEIRS, Robert | Director | 17 Kings Crescent G84 7RB Helensburgh Dunbartonshire | British | Group Finance Director | 2592770003 | |||||
TAGLIAFERRI, Mark Lee | Director | Flat 2 105 Cadogan Gardens SW3 2RF London | England | British | Director | 106792270001 | ||||
WHITEHEAD, Grahame Taylor | Director | Southlea 20 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | Bank Official | 1363570003 |
¿Tiene IBIS NO. 3 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creado el 14 may 2001 Entregado el 04 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over property (which there is none); fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 14 may 2001 Entregado el 31 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £10,000,000 | |
Breve descripción Legal mortgage over property(which there is none);fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 03 dic 1999 Entregado el 23 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 03 dic 1999 Entregado el 23 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The barons court hotel, walsallwood, west midlands; fixed charges over assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 03 dic 1999 Entregado el 23 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The northwick park hotel, harrow; fixed charges over assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 03 dic 1999 Entregado el 23 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The leafric hotel, broadgate, coventry, fixed charges over assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 03 dic 1999 Entregado el 23 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The lion gate hotel, hampton court, surrey; fixed charges over assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0