WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC140588 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de David Clifford Grant como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2025 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 16 páginas | AA | ||
Nombramiento de David Clifford Grant como director el 19 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de James Mccubbin Rowney como director el 19 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||
Modification des détails de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 abr 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cessation de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 abr 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||
Modification des détails de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 17 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Howard Nicholas Ferguson Martin como director el 04 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Brandwood como director el 14 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mark Brandwood el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr James Mccubbin Rowney el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cessation de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 24/25 st Andrew Square Edinburgh EH2 1AF a Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ el 09 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| MARTIN, Howard Nicholas Ferguson | Director | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | United Kingdom | British | 297622630001 | |||||||||
| CRAIG, Mark | Secretario | 2f2, 7 Polwarth Crescent EH11 1HP Edinburgh | British | 63130650003 | ||||||||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Secretario | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 33 Badger Walk EH52 5TW Broxburn West Lothian | British | 40027890002 | ||||||||||
| MARCHANT, Maria | Secretario | Flat 1,12 Church Rise Forest Hill SE23 2UD London | British | 79333440001 | ||||||||||
| MILLS, Alan Ewing | Secretario | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||||||
| SMITH, Carolyn | Secretario | 9 Bedford Court Mowbray Road Upper Norwood SE19 2RW London | British | 68031820001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| ADAMS, Aubrey John | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | England | British | 10219610001 | |||||||||
| AUBERY, Paul Richard | Director | 1 Malthouse Drive Regency Quay Chiswick W4 2NR London | British | 78253140001 | ||||||||||
| BARLOW, Laura Jane | Director | Bishopsgate 280 Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | England | British | 247369840001 | |||||||||
| BEATTIE, Robert Henry | Director | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 27224590001 | |||||||||
| BEATTIE, Robert Henry | Director | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 27224590001 | |||||||||
| BOSTOCK, Nathan Mark | Director | Bishopsgate 135 Bishopsgate London EC2M 3UR London 135 England | England | British | 182287900001 | |||||||||
| BRANDWOOD, Mark | Director | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | England | British | 204418370002 | |||||||||
| BRENA, Jose Guillermo | Director | 6 Gloucester Crescent NW1 7DS London | England | British | 88137650001 | |||||||||
| CARRARO, Philip Andrew | Director | 70 Onslow Gardens SW7 3QD London | United States Citizen | 64702980001 | ||||||||||
| CARTLEDGE, David Edmund | Director | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | 38897330001 | ||||||||||
| CHRISPIN, Simon Jonathan | Director | 41 Claygate Avenue AL5 2HE Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 62029940002 | |||||||||
| CULLINAN, Rory Malcolm | Director | Oakwood Court 25 Oakwood Court Abbotsbury Road W14 8JU London 25 England | England | British | 149327390001 | |||||||||
| CULLINAN, Rory Malcolm | Director | 25 Oakwood Court Abbotsbury Road W14 8JU London | England | British | 149327390001 | |||||||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Director | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||||||
| FOSTER, Kennedy Campbell | Director | 4 Deacons Court EH49 6BT Linlithgow West Lothian | British | 70070530001 | ||||||||||
| GOPINATHAN, Kavita | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | United Kingdom | Malaysian | 171269170001 | |||||||||
| GORDON, Helen Christine | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | England | British | 59902650001 | |||||||||
| GRANT, David Clifford | Director | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 161824340001 | |||||||||
| HOURICAN, Declan Joseph | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | Irish | 136011150001 | |||||||||
| HOURICAN, Declan Joseph | Director | Woodcore Hurst KT18 7DS Epsom 27 Surrey England | England | Irish | 136011150001 | |||||||||
| KENNEDY, Thomas Peter | Director | 36 Stock Road CM12 0BE Billericay Essex | England | British | 58560260002 | |||||||||
| LAMBERT, Mark Andrew | Director | Owls Castle Cottage Hog Hole Lane, Lamberhurst TN3 8BN Tunbridge Wells | England | British | 150167790001 | |||||||||
| MCADAM, Joy | Director | Bishopsgate 280 Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | England | British | 152916290002 | |||||||||
| MCLEAN, Miller Roy | Director | 3 Bonaly Crescent EH13 0EN Edinburgh | British | 83720001 | ||||||||||
| MILLER, John Thomas Henry | Director | 49 Barnton Park Avenue EH4 6HD Edinburgh Midlothian | British | 802080001 | ||||||||||
| MORRIS, Andrew James | Director | 39 Royston Road AL1 5NF St Albans Hertfordshire | British | 114950770001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. Head Office Nominees Limited | 06 abr 2016 | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Natwest Markets Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0