WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED

WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC140588
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Rbs Gogarburn
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta07 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence21 nov 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta07 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de David Clifford Grant como director el 31 dic 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2025 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    16 páginasAA

    Nombramiento de David Clifford Grant como director el 19 may 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Mccubbin Rowney como director el 19 may 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2024 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    16 páginasAA

    Modification des détails de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 abr 2024

    2 páginasPSC05

    Cessation de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 abr 2024

    1 páginasPSC07

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Modification des détails de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    17 páginasAA

    Nombramiento de Mr Howard Nicholas Ferguson Martin como director el 04 jul 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Brandwood como director el 14 jun 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    18 páginasAA

    Cambio de datos del director Mark Brandwood el 07 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Mccubbin Rowney el 07 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cessation de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC07

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 24/25 st Andrew Square Edinburgh EH2 1AF a Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ el 09 sept 2020

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Secretario corporativo
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro11360457
    249447430001
    MARTIN, Howard Nicholas Ferguson
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritish297622630001
    CRAIG, Mark
    2f2, 7 Polwarth Crescent
    EH11 1HP Edinburgh
    Secretario
    2f2, 7 Polwarth Crescent
    EH11 1HP Edinburgh
    British63130650003
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Secretario
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    MACGILLIVRAY, Shirley Margaret
    33 Badger Walk
    EH52 5TW Broxburn
    West Lothian
    Secretario
    33 Badger Walk
    EH52 5TW Broxburn
    West Lothian
    British40027890002
    MARCHANT, Maria
    Flat 1,12 Church Rise
    Forest Hill
    SE23 2UD London
    Secretario
    Flat 1,12 Church Rise
    Forest Hill
    SE23 2UD London
    British79333440001
    MILLS, Alan Ewing
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    Secretario
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    British1268780001
    SMITH, Carolyn
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    Secretario
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    British68031820001
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Secretario corporativo
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC269847
    169073830001
    ADAMS, Aubrey John
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    EnglandBritish10219610001
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Director
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARLOW, Laura Jane
    Bishopsgate
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Director
    Bishopsgate
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    EnglandBritish247369840001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Director
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish27224590001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Director
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish27224590001
    BOSTOCK, Nathan Mark
    Bishopsgate
    135 Bishopsgate London
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Director
    Bishopsgate
    135 Bishopsgate London
    EC2M 3UR London
    135
    England
    EnglandBritish182287900001
    BRANDWOOD, Mark
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    EnglandBritish204418370002
    BRENA, Jose Guillermo
    6 Gloucester Crescent
    NW1 7DS London
    Director
    6 Gloucester Crescent
    NW1 7DS London
    EnglandBritish88137650001
    CARRARO, Philip Andrew
    70 Onslow Gardens
    SW7 3QD London
    Director
    70 Onslow Gardens
    SW7 3QD London
    United States Citizen64702980001
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Director
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    British38897330001
    CHRISPIN, Simon Jonathan
    41 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    41 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish62029940002
    CULLINAN, Rory Malcolm
    Oakwood Court
    25 Oakwood Court Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    25
    England
    Director
    Oakwood Court
    25 Oakwood Court Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    25
    England
    EnglandBritish149327390001
    CULLINAN, Rory Malcolm
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    Director
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    EnglandBritish149327390001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Director
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FOSTER, Kennedy Campbell
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    Director
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    British70070530001
    GOPINATHAN, Kavita
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    United KingdomMalaysian171269170001
    GORDON, Helen Christine
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    EnglandBritish59902650001
    GRANT, David Clifford
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Director
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritish161824340001
    HOURICAN, Declan Joseph
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandIrish136011150001
    HOURICAN, Declan Joseph
    Woodcore Hurst
    KT18 7DS Epsom
    27
    Surrey
    England
    Director
    Woodcore Hurst
    KT18 7DS Epsom
    27
    Surrey
    England
    EnglandIrish136011150001
    KENNEDY, Thomas Peter
    36 Stock Road
    CM12 0BE Billericay
    Essex
    Director
    36 Stock Road
    CM12 0BE Billericay
    Essex
    EnglandBritish58560260002
    LAMBERT, Mark Andrew
    Owls Castle Cottage
    Hog Hole Lane, Lamberhurst
    TN3 8BN Tunbridge Wells
    Director
    Owls Castle Cottage
    Hog Hole Lane, Lamberhurst
    TN3 8BN Tunbridge Wells
    EnglandBritish150167790001
    MCADAM, Joy
    Bishopsgate
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Director
    Bishopsgate
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    EnglandBritish152916290002
    MCLEAN, Miller Roy
    3 Bonaly Crescent
    EH13 0EN Edinburgh
    Director
    3 Bonaly Crescent
    EH13 0EN Edinburgh
    British83720001
    MILLER, John Thomas Henry
    49 Barnton Park Avenue
    EH4 6HD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    49 Barnton Park Avenue
    EH4 6HD Edinburgh
    Midlothian
    British802080001
    MORRIS, Andrew James
    39 Royston Road
    AL1 5NF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    39 Royston Road
    AL1 5NF St Albans
    Hertfordshire
    British114950770001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WEST REGISTER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    06 abr 2016
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc012097
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    The Royal Bank Of Scotland Plc
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    06 abr 2016
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1948
    Lugar de registroRegister Of Members
    Número de registroSc090312
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Natwest Markets Plc
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    06 abr 2016
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1948
    Lugar de registroCompanies House Scotland
    Número de registroSc090312
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0