SCOTIA HOMES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SCOTIA HOMES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC141011 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SCOTIA HOMES LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra SCOTIA HOMES LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTIA HOMES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOTIA DEVELOPMENTS LIMITED | 14 jul 2000 | 14 jul 2000 |
| ABERDEENSHIRE ASSURED TENANCIES LIMITED | 26 mar 1993 | 26 mar 1993 |
| PANELNEW LIMITED | 02 nov 1992 | 02 nov 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTIA HOMES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SCOTIA HOMES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 18 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTIA HOMES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Graham Reid como director el 31 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 27 páginas | AA | ||
Registro de la carga SC1410110023, creada el 29 ene 2025 | 6 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Hms Secretaries Limited como secretario el 29 feb 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 30 jun 2023 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Patrick Joseph Boyle como director el 18 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cancelación total de la carga 21 | 4 páginas | MR04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 25 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de William Martin Bruce como director el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew John Lonie como director el 30 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr William Martin Bruce el 27 jul 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2020 | 28 páginas | AA | ||
Nombramiento de Graham Reid como director el 04 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr William Martin Bruce el 26 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 abr 2020 au 30 jun 2020 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Hms Secretaries Limited como secretario el 22 jul 2020 | 2 páginas | AP04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ a The Ca'd'oro 45 Gordon Street Glasgow G1 3PE el 22 jul 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de William Lind Macleod como director el 28 may 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SCOTIA HOMES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATON, Carol Anne | Director | Balmacassie AB41 8QR Ellon 1 Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | 135598850001 | |||||||||||||
| BEGBIE, Richard Gerard | Director | Simpson Street AB52 6TW Insch 24 Aberdeenshire United Kingdom | Scotland | British | 188667580002 | |||||||||||||
| CAMERON, David John | Director | 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow The Ca'D'Oro Scotland | Scotland | British | 125212090002 | |||||||||||||
| GERRARD, Gary James | Director | Queen's Grove Hazlehead AB15 8HE Aberdeen 2 Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 157052200001 | |||||||||||||
| LINTON, Bruce Reid | Director | 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow The Ca'D'Oro Scotland | Scotland | British | 263302000001 | |||||||||||||
| ZANRE, Michael Luigi Peter | Secretario | 27 Hillview Terrace Cults AB15 9HJ Aberdeen | British | 248390002 | ||||||||||||||
| BURNESS PAULL LLP | Secretario corporativo | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 202456990001 | ||||||||||||||
| HMS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow The Ca'D'Oro Scotland |
| 138735420001 | ||||||||||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||||||||||
| BAIN, Norman | Director | 61 King Street AB42 1QJ Peterhead Aberdeenshire | British | 74679360001 | ||||||||||||||
| BOYLE, Patrick Joseph | Director | Balmacassie AB41 8QR Ellon 1 Aberdeenshire Scotland | Scotland | Irish | 159918790003 | |||||||||||||
| BRUCE, William Martin | Director | 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow The Ca'D'Oro Scotland | Scotland | British | 19099160011 | |||||||||||||
| BRUCE, William Henry | Director | Logie House AB41 8LH Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 121480001 | |||||||||||||
| BURNETT, Stephen | Director | Riversfield Castle Road AB41 9EY Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 34952260002 | |||||||||||||
| DAVIDSON, Ronald | Director | Cookston AB41 8DE Ellon Aberdeenshire | British | 906650001 | ||||||||||||||
| DRYBURGH, Roy Smith | Director | Balmacassie AB41 8QR Ellon 1 Aberdeenshire Scotland | United Kingdom | British | 205236740001 | |||||||||||||
| FAIRLIE, Francis Dominic | Director | 5 Louisville Avenue AB15 4TT Aberdeen | Scotland | British | 48091860001 | |||||||||||||
| HARDIE, Richard Henry | Director | Mains Of Waterton Auchmacoy AB41 8RE Ellon Aberdeenshire | British | 34735480002 | ||||||||||||||
| JACK, Ian | Director | 11 Cairnhill Drive AB43 5ST Fraserburgh Aberdeenshire | British | 326560002 | ||||||||||||||
| LONIE, Andrew John | Director | Udny Green AB41 7RR Ellon South Lodge Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | 134346490003 | |||||||||||||
| MACLEOD, William Lind | Director | 4 Fechil Brae AB41 8NS Ellon Aberdeenshire | United Kingdom | British | 37035550002 | |||||||||||||
| MILNE, Lawrence Brian | Director | Brackenridge AB41 9DG Ellon Aberdeenshire | British | 944050001 | ||||||||||||||
| REID, Graham | Director | 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow The Ca'D'Oro Scotland | Scotland | Scottish | 283194560001 | |||||||||||||
| SHEPHERD, Christopher George Mackie | Director | Pitmillan Newburgh AB41 0AL Ellon Aberdeenshire | United Kingdom | British | 34952250001 | |||||||||||||
| TAYLOR, James Louis | Director | 81 Forman Drive AB42 6XG Peterhead Aberdeenshire | British | 104090001 | ||||||||||||||
| TAYLOR, Michael John | Director | Fechil Lodge AB41 8NR Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 89410400001 | |||||||||||||
| THOM, William Derek | Director | 60 Springfield Road AB1 7RS Aberdeen | British | 34952200001 | ||||||||||||||
| THOMSON, Derrick Raymond Cruickshank | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 131095200002 | |||||||||||||
| WATT, Dennis Watson | Director | 94 Queens Road AB15 4YQ Aberdeen | United Kingdom | British | 55791220003 | |||||||||||||
| ZANRE, Michael Luigi Peter | Director | 27 Hillview Terrace Cults AB15 9HJ Aberdeen | United Kingdom | British | 248390002 | |||||||||||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Director designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SCOTIA HOMES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotia Homes (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0