KEMIRA PURTON LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | KEMIRA PURTON LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC141139 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KEMIRA PURTON LTD?
- Recolección, tratamiento y suministro de agua (36000) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
¿Dónde se encuentra KEMIRA PURTON LTD?
| Dirección de la sede social | C/O Interpath Ltd 130 St. Vincent Street G2 5HF Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KEMIRA PURTON LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PURTON CARBONS LIMITED | 14 dic 1992 | 14 dic 1992 |
| HIGHROVE LIMITED | 10 nov 1992 | 10 nov 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KEMIRA PURTON LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 dic 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 12 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KEMIRA PURTON LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 27 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 10 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 27 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KEMIRA PURTON LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ Scotland a C/O Interpath Ltd 130 st. Vincent Street Glasgow G2 5HF el 11 mar 2026 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2024 au 30 dic 2024 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elaine Wharton como director el 30 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC1411390002 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC1411390003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación parcial de la carga SC1411390002 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación parcial de la carga SC1411390003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Notification de Kemira Oyj en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept 2024 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed purton carbons LIMITED\certificate issued on 05/09/24 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr David John Normington como director el 02 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Elaine Wharton como director el 02 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 45 Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate Glasgow G32 8RF a 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ el 05 sept 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cessation de Norit (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anie Onaiza como director el 02 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jie Chen como secretario el 02 sept 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bartholomeus Petrus Genemans como director el 02 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital el 19 ago 2024
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KEMIRA PURTON LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMINGTON, David John | Director | Bowling Park Drive BD4 7TT Bradford Kemira Chemicals (Uk) Ltd England | United Kingdom | British | 241279870003 | |||||||||
| BEST, Laura | Secretario | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 | 188146150001 | |||||||||||
| CHEN, Jie, Ms. | Secretario | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 | 239462550001 | |||||||||||
| HENSHAW, Sharon Ann | Secretario | Sully Moors Road Sully CF64 5RP Penarth C/O Cabot Vale Of Glamorgan Wales | 191858390001 | |||||||||||
| JOSEPH, Marc | Secretario | 5 Dunure Drive Newton Mearns G77 5TH Glasgow Lanarkshire | British | 125563170001 | ||||||||||
| LAIRD, Alan Charles Colin, Director | Secretario | 40 Norwood Drive Whitecraigs G46 7LS Glasgow | British | 31770300001 | ||||||||||
| REID, Brian | Secretario designado | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||
| THERON, Louis Eduard | Secretario | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 Scotland | 150533210001 | |||||||||||
| VERSTERRE, Jeff | Secretario | Clydesmill Place Cambuslang Industrial Place G32 8RF Glasgow | British | 134237580003 | ||||||||||
| ANDERSON FYFE LLP | Secretario corporativo | The Grosvenor Building 72 Gordon Street G1 3RN Glasgow Lanarkshire | 109972520001 | |||||||||||
| BARRACK, Gavin James | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 Scotland | Scotland | British | 73490870002 | |||||||||
| CHAPLIN, David Henry | Director | 10 West Chapelton Crescent Bearsden G61 2DE Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 485330001 | |||||||||
| CHRYSTALL, David James | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 | Scotland | British | 234848300001 | |||||||||
| DE KEIZER, Cornelis | Director | Wagnerlaan 26 1217 Np Hilversum The Netherlands | Dutch | 633030002 | ||||||||||
| DEACON, John Nigel | Director | Highfields Rickford Rise, Burrington BS40 7AN Bristol Avon | British | 67007250001 | ||||||||||
| GANZEBOOM, Paulus Johannes Bernardus | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 Scotland | Netherlands | Dutch | 147496420001 | |||||||||
| GENEMANS, Bartholomeus Petrus | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 Scotland | Netherlands | Dutch | 147496340001 | |||||||||
| KNUTTEL, Maarten | Director | Clydesmill Place Cambuslang Industrial Place G32 8RF Glasgow | Netherlands | Dutch | 56379480002 | |||||||||
| LAIRD, Alan Charles Colin, Director | Director | 40 Norwood Drive Whitecraigs G46 7LS Glasgow | Scotland | British | 31770300001 | |||||||||
| MABBOTT, Stephen | Director designado | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow Strathclyde | British | 900007110001 | ||||||||||
| MALONEY, Marc | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 | United States | American | 187070360001 | |||||||||
| MATERS, Gerardus Christiaan Paulus Jacobus | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 Scotland | Usa | Dutch | 161298630001 | |||||||||
| MORTON, Ian Charles | Director | 21 Verlands Congresbury BS19 5BL Bristol Avon | British | 21265190001 | ||||||||||
| NIELD, Andrew Simon | Director | Foxhollow Stoke Hill Chew Stoke BS40 8XG Bristol | United Kingdom | British | 69491180003 | |||||||||
| ONAIZA, Anie | Director | 115 Amesbury Drive Hingham, Ma 02043 115 Amesbury Drive United States | United States | American | 280101740001 | |||||||||
| PARSONS, Alan | Director | 30 Channel Road BS21 7BY Clevedon North Somerset | United Kingdom | British | 19584530003 | |||||||||
| PARSONS, Alan | Director | 30 Channel Road BS21 7BY Clevedon North Somerset | United Kingdom | British | 19584530003 | |||||||||
| THERON, Louis Eduard | Director | Clydesmill Place Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow 45 | Scotland | British | 187065920001 | |||||||||
| WHARTON, Elaine | Director | Bowling Park Drive BD4 7TT Bradford Kemira Chemicals Uk Ltd England | United Kingdom | British | 237690760001 | |||||||||
| NORIT EAPA HOLDING B.V. | Director corporativo | 3812 Pm Amersfoort The Netherlands Nijverheidsweg-Noord 72 Netherlands |
| 147496820002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KEMIRA PURTON LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemira Oyj | 02 sept 2024 | Energiakatu Fi-00180 Helsinki 4 Finland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Norit (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Clydesmill Industrial Estate G32 8RF Glasgow Clydesmill Place Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Cabot Corporation Inc. | 06 abr 2016 | Two Seaport Lane Suite 1300 Boston Cabot Corporation Ma 02210-2019 United States | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KEMIRA PURTON LTD algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0