ASHBOURNE GROUP UK LIMITED

ASHBOURNE GROUP UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASHBOURNE GROUP UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC141431
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ASHBOURNE LIMITED04 nov 199404 nov 1994
    DALGLEN (NO. 504) LIMITED27 ene 199327 ene 1993
    ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED20 ene 199320 ene 1993
    DALGLEN (NO. 504) LIMITED25 nov 199225 nov 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Notificación de la finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4(Scot)

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 17 ago 2012

    1 páginasTM01

    Notificación del acta de la reunión que aprueba el acuerdo voluntario de los acreedores

    4 páginas1.1(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland el 20 ene 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ene 2012

    Estado de capital el 18 ene 2012

    • Capital: GBP 5,364,860
    SH01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    30 páginasAA

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU el 27 jul 2010

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Enter into various agreements 14/05/2010
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009

    26 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de un director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Lynn Fearn como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Director
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304650001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secretario
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    Secretario designado corporativo
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    900005750001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Director
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Director
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Director
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Director
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    British2996750001
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Director
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Director
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    Director
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    British53339290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Director
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Director
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritish130867640001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Director
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Director
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Director
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritish111188390002
    FOULKES, Kamma
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    Director
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Director
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GUEST, Walter Henry
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    Director
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    British4200040001
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Director
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Director
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Director
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LEVICK, Ann
    57a Highlands Heath
    SW15 3TX London
    Director
    57a Highlands Heath
    SW15 3TX London
    British37880870004
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Director
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    Director
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish110640170001

    ¿Tiene ASHBOURNE GROUP UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of acquisition agreement
    Creado el 01 feb 1993
    Entregado el 19 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    In the charge of acquisition agreement topco as beneficial owner charges by way of first fixed charge to the security agent as a continuing security fot the secured obligations the full benefit of the acquisition agreement and all thhe right title and interest whatsoever of topco therein (together the "charged property").
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 feb 1993Registro de un cargo (410)
    • 29 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene ASHBOURNE GROUP UK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0