ASHBOURNE GROUP UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ASHBOURNE GROUP UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC141431 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ASHBOURNE LIMITED | 04 nov 1994 | 04 nov 1994 |
| DALGLEN (NO. 504) LIMITED | 27 ene 1993 | 27 ene 1993 |
| ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED | 20 ene 1993 | 20 ene 1993 |
| DALGLEN (NO. 504) LIMITED | 25 nov 1992 | 25 nov 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Notificación de la finalización del acuerdo voluntario | 6 páginas | 1.4(Scot) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 17 ago 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notificación del acta de la reunión que aprueba el acuerdo voluntario de los acreedores | 4 páginas | 1.1(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland el 20 ene 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Midmer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU el 27 jul 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de un director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lynn Fearn como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Director | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Secretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretario | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158304650001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secretario | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS | Secretario designado corporativo | 11 Glenfinlas Street Edinburgh Lothian | 900005750001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Director | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Director | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Director | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Director | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BROKE, Michael Haviland Adlington | Director | 7 Westmead Roehampton SW15 5BH London | British | 2996750001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Director | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Director | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Director | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| DENNY, Nigel John | Director | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Director | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEARN, Lynn | Director | Elmwood Drive DE55 7QJ Alfreton 24 Derbyshire | United Kingdom | British | 130867640001 | |||||
| FEENEY, Martin | Director | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Director | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Director | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| FOULKES, Kamma | Director | 17 Lower Castle Street NP7 5EE Abergavenny Monmouthshire | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Director | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GUEST, Walter Henry | Director | Spindleberry Pine Avenue GU15 2LY Camberley Surrey | British | 4200040001 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Director | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Director | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Director | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LEVICK, Ann | Director | 57a Highlands Heath SW15 3TX London | British | 37880870004 | ||||||
| LOCK, Jason David | Director | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Director | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Director | The Castle Business Park, Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling C/O Southern Cross Healthcare Scotland Scotland | England | British | 110640170001 |
¿Tiene ASHBOURNE GROUP UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of acquisition agreement | Creado el 01 feb 1993 Entregado el 19 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción In the charge of acquisition agreement topco as beneficial owner charges by way of first fixed charge to the security agent as a continuing security fot the secured obligations the full benefit of the acquisition agreement and all thhe right title and interest whatsoever of topco therein (together the "charged property"). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ASHBOURNE GROUP UK LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA) |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0