MACRAE FOODS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MACRAE FOODS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC141744 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MACRAE FOODS LIMITED?
- Procesamiento y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (10200) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra MACRAE FOODS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MACRAE FOODS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MOUNTWEST ONE LIMITED | 16 dic 1992 | 16 dic 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MACRAE FOODS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MACRAE FOODS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS el 14 may 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA a C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 17 jul 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 09 abr 2020
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jenny Nancy Loncaster como director el 25 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Mark Busby como director el 12 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2019 au 31 mar 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont como director el 04 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited como secretario el 04 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Wilkin Chapman Company Secretarial Service Ltd el 19 nov 2018 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Herbert Lofts como director el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Mark Busby como director el 31 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Herbert Lofts como director el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MACRAE FOODS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Director | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| GAULT, Sandra | Secretario | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
| STRONACHS | Secretario designado corporativo | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 900000500001 | |||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| ALLAN, David Martin | Director | Silverdale South Avenue Cults AB15 9LP Aberdeen Aberdeenshire | British | 41797230002 | ||||||||||
| ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Director | Allee Du Cloitre 7 FOREIGN Brussels 1000 Belgium | British | 71513420001 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Director | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BROWN, Cameron Matthew | Director | 26 St Clair Wynd Newburgh AB41 6DZ Ellon Aberdeenshire | British | 61176080001 | ||||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | Dutch | 166335910001 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Director | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| HAZELDEAN, James William | Director | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 10359650007 | |||||||||
| KNUTTON, Roderick Leonard | Director | Loanhead Of Pitinnan Daviot AB51 0JH Inverurie Aberdeenshire | British | 35167880001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Director | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Director | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 185293570001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Director | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| PORTEOUS, Ronald | Director | Coirseunan Lodge Whitecairns AB23 8UN Aberdeen | British | 42171410001 | ||||||||||
| WRIGHT, Robin James Morrison | Director | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | 71513490001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MACRAE FOODS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06 abr 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MACRAE FOODS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 06 nov 2008 Entregado el 19 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh, aberdeen ABN59533. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 oct 2008 Entregado el 05 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 sept 2008 Entregado el 03 oct 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 30 mar 2007 Entregado el 04 abr 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh ABN59533. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 mar 2007 Entregado el 31 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 28 mar 2006 Entregado el 31 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción The subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh (title number abn 59533). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 mar 2006 Entregado el 29 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 12 dic 2005 Entregado el 20 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 07 dic 2005 Entregado el 28 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects on north side of watermill road, fraserburgh ABN59533. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 14 jul 2004 Entregado el 22 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjectas lying on the northside of watermill road, fraserburgh--title number ABN59533. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 jun 2004 Entregado el 10 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 ago 2000 Entregado el 15 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 ago 2000 Entregado el 15 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 22 feb 1993 Entregado el 03 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene MACRAE FOODS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0