SIG 1 HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SIG 1 HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC143950 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WEST REGISTER (INVESTMENTS) LIMITED | 25 nov 1994 | 25 nov 1994 |
| ROBOSCOT (10) LIMITED | 20 abr 1993 | 20 abr 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Thomas Richard Hamilton Reddy como director el 23 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Niamh Simms como director el 23 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Niamh Simms como director el 22 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kavita Gopinathan como director el 22 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 34 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Natwest Group Secretarial Services Limited el 03 ago 2020 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Guy Mason el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Kavita Gopinathan el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Rbs Secretarial Services Limited el 16 sept 2020 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 24/25 st Andrew Square Edinburgh EH2 1AF a Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ el 03 ago 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2020 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
| MASON, Robert Guy | Director | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | England | British | 236198110001 | |||||||||
| REDDY, Thomas Richard Hamilton | Director | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | England | British | 325437880001 | |||||||||
| CRAIG, Mark | Secretario | 2f2, 7 Polwarth Crescent EH11 1HP Edinburgh | British | 63130650003 | ||||||||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Secretario | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 33 Badger Walk EH52 5TW Broxburn West Lothian | British | 40027890002 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||||||
| MARCHANT, Maria | Secretario | Flat 1,12 Church Rise Forest Hill SE23 2UD London | British | 79333440001 | ||||||||||
| MILLS, Alan Ewing | Secretario | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||||||
| SMITH, Carolyn | Secretario | 9 Bedford Court Mowbray Road Upper Norwood SE19 2RW London | British | 68031820001 | ||||||||||
| BARLOW, Laura Jane | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London 280 | England | British | 247369840001 | |||||||||
| BEATTIE, Robert Henry | Director | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 27224590001 | |||||||||
| BOSTOCK, Nathan Mark | Director | Bishopsgate 135 Bishopsgate London EC2M 3UR London 135 England | England | British | 182287900001 | |||||||||
| BRENA, Jose Guillermo | Director | 6 Gloucester Crescent NW1 7DS London | England | British | 88137650001 | |||||||||
| CAMPBELL, Hew | Director | 44 Castleknowe Gardens Kirkton Park ML8 5UX Carluke Scotland | British | 1416100007 | ||||||||||
| CARRARO, Philip Andrew | Director | 70 Onslow Gardens SW7 3QD London | United States Citizen | 64702980001 | ||||||||||
| CHRISPIN, Simon Jonathan | Director | 41 Claygate Avenue AL5 2HE Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 62029940002 | |||||||||
| CULLINAN, Rory Malcolm | Director | Oakwood Court 25 Oakwood Court Abbotsbury Road W14 8JU London 25 England | England | British | 149327390001 | |||||||||
| CULLINAN, Rory Malcolm | Director | 25 Oakwood Court Abbotsbury Road W14 8JU London | England | British | 149327390001 | |||||||||
| DAVISON, John Michael | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London 280 | England | British | 158870560001 | |||||||||
| DICKINSON, Alan Peter | Director | TN5 | England | British | 190869750001 | |||||||||
| FOSTER, Kennedy Campbell | Director | 4 Deacons Court EH49 6BT Linlithgow West Lothian | British | 70070530001 | ||||||||||
| GOPINATHAN, Kavita | Director | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | England | Malaysian | 266112890001 | |||||||||
| GOPINATHAN, Kavita | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London 280 | United Kingdom | Malaysian | 171269170001 | |||||||||
| HOURICAN, Declan Joseph | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | Irish | 136011150001 | |||||||||
| HOURICAN, Declan Joseph | Director | Woodcore Hurst KT18 7DS Epsom 27 Surrey England | England | Irish | 136011150001 | |||||||||
| KENNEDY, Thomas Peter | Director | 36 Stock Road CM12 0BE Billericay Essex | England | British | 58560260002 | |||||||||
| LAMBERT, Mark Andrew | Director | Owls Castle Cottage Hog Hole Lane, Lamberhurst TN3 8BN Tunbridge Wells | England | British | 150167790001 | |||||||||
| MACGREGOR, Fiona Jane | Director | 21 Aysgarth Road Dulwich SE21 7JR London | United Kingdom | British | 94672270001 | |||||||||
| MAIR, Angus James Murray, Mr. | Director | 1 Belford Park EH4 3DP Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 85930020003 | |||||||||
| MCKEAN, Alan Wallace | Director | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | 1019950002 | ||||||||||
| MCNULTY, Cecilia Ann | Director | 6 Wentworth Mansions Keats Grove NW3 2RL London | British | 42622920002 | ||||||||||
| MORRIS, Andrew James | Director | 39 Royston Road AL1 5NF St Albans Hertfordshire | British | 114950770001 | ||||||||||
| PARSONS, Christopher John | Director | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | England | British | 236200900001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Bhupendra | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 201653410001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SIG 1 HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rbs Aa Holdings (Uk) Limited | 01 oct 2017 | EC2M 4AA London 250, Bishopsgate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0