NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC146648 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?
- Edición de revistas y publicaciones periódicas de consumo y negocios (58142) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 200 Renfield Street Glasgow G2 3QB |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SMG MAGAZINES LIMITED | 26 jun 2000 | 26 jun 2000 |
| CALEDONIAN MAGAZINES LIMITED | 28 sept 1993 | 28 sept 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 23 dic 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 26 nov 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 13 ene 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 13 ene 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Simon Alton Westrop el 13 ene 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Henry Kennedy Faure Walker el 13 ene 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Davidson como director el 11 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Henry Kennedy Faure Walker como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 dic 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 dic 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 23 mar 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPENTER, Neil Edward | Secretario | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
| WESTROP, Simon Alton | Secretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
| FAURE WALKER, Henry Kennedy | Director | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 187012370001 | |||||
| HUNTER, Paul Anthony | Director | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | 69320190004 | |||||
| CLARKE, Sara | Secretario | 17 Queens Drive Westerwood G68 0HW Glasgow | British | 77963580001 | ||||||
| DAVIDSON, Dawn | Secretario | Langhaugh Carmichael ML12 6PQ Biggar Lanarkshire | British | 51065860001 | ||||||
| HUGHES, Gary William | Secretario | 64 Crown Road North Dowanhill G12 9HW Glasgow | British | 72256160002 | ||||||
| HUNTER, Paul Anthony | Secretario | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
| SUMMERS, Gavin Brown | Secretario | 642 Clarkston Road G44 3YS Glasgow | British | 37360660002 | ||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| BROWN, James Thomson | Director | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | 4154210013 | ||||||
| DAVIDSON, Paul | Director | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 46356560004 | |||||
| FLANAGAN, Andrew Henry | Director | 7 Collylinn Road Bearsden G61 4PN Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 42787120004 | |||||
| HUDSON, Desmond Gerard | Director | 113 Chancery Lane WC2A 1PL London The Law Societys Hall | United Kingdom | British | 32094360003 | |||||
| HUGHES, Gary William | Director | 64 Crown Road North Dowanhill G12 9HW Glasgow | Uk | British | 72256160002 | |||||
| JOHNSTONE, Joseph Blair | Director | 6 Margarets Place ML9 2HQ Larkhall Lanarkshire | British | 37530220003 | ||||||
| JONES, Simon Hyde | Director | Evenlode Cottage Foxcote House High Street GL56 0AD Moreton In Marsh Gloucestershire | British | 37530190003 | ||||||
| KANE, William James | Director | 11 St Peters Street Islington N1 8JD London | British | 73972820001 | ||||||
| LEITCH, Graham | Director | 11 Priors Grange Torphichen EH48 4QN Bathgate West Lothian | British | 37530260003 | ||||||
| MACDONALD, Angus John | Director | 11 Great Western Terrace G12 0UP Glasgow | British | 4120001 | ||||||
| MACDONALD, Ronald Sutherland | Director | 135 Stewarton Drive G72 8DH Cambuslang | United Kingdom | British | 145418810001 | |||||
| MCKELVIE, Fiona | Director | Whiteoaks, 11 Lochbroom Drive Newton Mearns G77 5PF Glasgow | British | 78491980001 | ||||||
| PARK, James Clement | Director | Balmaha Loch Lomond G63 0JQ Glasgow The Moorings United Kingdom | United Kingdom | British | 135739890001 | |||||
| PERMAN, Raymond John | Director | 14 East Claremont Street EH7 4JP Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 380430001 | |||||
| URE, Michael Glen Mcgregor | Director | 14 Birchgrove Houston PA6 7DF Johnstone Renfrewshire | British | 37530150001 | ||||||
| WATT, William George | Director | 34 Wilton Street North Kelvinside G20 6LE Glasgow | British | 72664400001 | ||||||
| MD DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow Pacific House | 900005100001 | |||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Director designado corporativo | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 |
¿Tiene NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 18 jul 2002 Entregado el 31 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over property defined in the schedule; various fixed charges as defined in the schedule attached to the mortgage document; floating charge over all assets. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 03 oct 1994 Entregado el 21 oct 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by the company and others | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Supplemental debenture | Creado el 03 oct 1994 Entregado el 21 oct 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by the company and others | |
Breve descripción See ch microfiche. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 31 dic 1993 Entregado el 11 ene 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by the company and others | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Debenture | Creado el 31 dic 1993 Entregado el 11 ene 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by the company and others | |
Breve descripción See companies house microfiche. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0