NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED

NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEWSQUEST MAGAZINES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC146648
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    • Edición de revistas y publicaciones periódicas de consumo y negocios (58142) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    200 Renfield Street
    Glasgow
    G2 3QB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SMG MAGAZINES LIMITED26 jun 200026 jun 2000
    CALEDONIAN MAGAZINES LIMITED28 sept 199328 sept 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 ene 2016

    Estado de capital el 04 ene 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Estado de capital el 23 dic 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 26 nov 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014

    6 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 13 ene 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 13 ene 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del secretario Simon Alton Westrop el 13 ene 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Henry Kennedy Faure Walker el 13 ene 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2015

    Estado de capital el 12 ene 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Paul Davidson como director el 11 nov 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Henry Kennedy Faure Walker como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 ene 2014

    Estado de capital el 07 ene 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 dic 2010

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 23 mar 2010

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARPENTER, Neil Edward
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    British90209080001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British109662340001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish187012370001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglish69320190004
    CLARKE, Sara
    17 Queens Drive
    Westerwood
    G68 0HW Glasgow
    Secretario
    17 Queens Drive
    Westerwood
    G68 0HW Glasgow
    British77963580001
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Secretario
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Secretario
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    British72256160002
    HUNTER, Paul Anthony
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    Secretario
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    British69320190002
    SUMMERS, Gavin Brown
    642 Clarkston Road
    G44 3YS Glasgow
    Secretario
    642 Clarkston Road
    G44 3YS Glasgow
    British37360660002
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secretario designado corporativo
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BROWN, James Thomson
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    Director
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    British4154210013
    DAVIDSON, Paul
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish46356560004
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    HUDSON, Desmond Gerard
    113 Chancery Lane
    WC2A 1PL London
    The Law Societys Hall
    Director
    113 Chancery Lane
    WC2A 1PL London
    The Law Societys Hall
    United KingdomBritish32094360003
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Director
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    JOHNSTONE, Joseph Blair
    6 Margarets Place
    ML9 2HQ Larkhall
    Lanarkshire
    Director
    6 Margarets Place
    ML9 2HQ Larkhall
    Lanarkshire
    British37530220003
    JONES, Simon Hyde
    Evenlode Cottage Foxcote House
    High Street
    GL56 0AD Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Director
    Evenlode Cottage Foxcote House
    High Street
    GL56 0AD Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British37530190003
    KANE, William James
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    Director
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    British73972820001
    LEITCH, Graham
    11 Priors Grange
    Torphichen
    EH48 4QN Bathgate
    West Lothian
    Director
    11 Priors Grange
    Torphichen
    EH48 4QN Bathgate
    West Lothian
    British37530260003
    MACDONALD, Angus John
    11 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    Director
    11 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    British4120001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Director
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritish145418810001
    MCKELVIE, Fiona
    Whiteoaks, 11 Lochbroom Drive
    Newton Mearns
    G77 5PF Glasgow
    Director
    Whiteoaks, 11 Lochbroom Drive
    Newton Mearns
    G77 5PF Glasgow
    British78491980001
    PARK, James Clement
    Balmaha
    Loch Lomond
    G63 0JQ Glasgow
    The Moorings
    United Kingdom
    Director
    Balmaha
    Loch Lomond
    G63 0JQ Glasgow
    The Moorings
    United Kingdom
    United KingdomBritish135739890001
    PERMAN, Raymond John
    14 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Midlothian
    Director
    14 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish380430001
    URE, Michael Glen Mcgregor
    14 Birchgrove
    Houston
    PA6 7DF Johnstone
    Renfrewshire
    Director
    14 Birchgrove
    Houston
    PA6 7DF Johnstone
    Renfrewshire
    British37530150001
    WATT, William George
    34 Wilton Street
    North Kelvinside
    G20 6LE Glasgow
    Director
    34 Wilton Street
    North Kelvinside
    G20 6LE Glasgow
    British72664400001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Director designado corporativo
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Director designado corporativo
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001

    ¿Tiene NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 18 jul 2002
    Entregado el 31 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over property defined in the schedule; various fixed charges as defined in the schedule attached to the mortgage document; floating charge over all assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 2002Registro de un cargo (410)
    • 10 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 03 oct 1994
    Entregado el 21 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transacciones
    • 21 oct 1994Registro de un cargo (410)
    • 21 oct 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 04 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Supplemental debenture
    Creado el 03 oct 1994
    Entregado el 21 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    See ch microfiche.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transacciones
    • 21 oct 1994Registro de un cargo (410)
    • 04 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 31 dic 1993
    Entregado el 11 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 11 ene 1994Registro de un cargo (410)
    • 21 oct 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 21 oct 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 04 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Debenture
    Creado el 31 dic 1993
    Entregado el 11 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    See companies house microfiche.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 11 ene 1994Registro de un cargo (410)
    • 04 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0