SULZER (ABERDEEN) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SULZER (ABERDEEN) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC147952 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
- fabricación de otras maquinarias de propósito especial n.c.o.p. (28990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Formartine House Castle Street Castlepark Industrial Estate AB41 9RF Ellon Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SULZER WOOD LIMITED | 10 ene 1994 | 10 ene 1994 |
| ALLCAST LIMITED | 09 dic 1993 | 09 dic 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de John Rowland Davenport como director el 10 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr David Jonathon Ellis como director el 10 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 35 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Helen Hanlon como director el 21 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Vanessa Jackson como director el 21 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Ravin Pillay Ramsamy como director el 21 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Holger Hans-Jochen Ruckstuhl como director el 20 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 35 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Philippe Andreas Dewitz como director el 23 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 41 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Christian Powles como director el 17 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr John Rowland Davenport como director el 17 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 36 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Christian Powles el 02 jun 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de . Castle Road Industrial Estate Ellon Aberdeenshire AB41 9RF Scotland a Formartine House Castle Street Castlepark Industrial Estate Ellon AB41 9RF el 19 abr 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cessation de Wood Group Engineering & Operations Support Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 mar 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de Iain Angus Jones como secretario el 22 mar 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Ravin Pillay Ramsamy como director el 22 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Holger Hans-Jochen Ruckstuhl como director el 22 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIS, David Jonathon | Director | Castle Street Castlepark Industrial Estate AB41 9RF Ellon Formartine House Scotland | Scotland | British | 285759210001 | |||||
| HANLON, Helen | Director | 6502 Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7WL Birmingham 6502 England | England | British | 336149170001 | |||||
| JACKSON, Vanessa | Director | Manor Mill Lane LS11 8BR Leeds Sulzer (Uk) Holdings United Kingdom | United Kingdom | British | 327078770001 | |||||
| BROWN, Charles Nicholas | Secretario | Stoneyards Farm Menie By Balmedie AB41 0YJ Aberdeen Grampian | British | 36752260001 | ||||||
| BROWN, Robert Muirhead Birnie | Secretario | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | 153996880001 | |||||||
| GOOD, Graham | Secretario | 22 Gladstone Place AB10 6XA Aberdeen | British | 57781370001 | ||||||
| JOHNSON, Ian | Secretario | John Wood House, Greenwell Road East Tullos AB12 3AX Aberdeen | British | 102664100004 | ||||||
| JONES, Iain Angus | Secretario | Castle Road Industrial Estate AB41 9RF Ellon . Aberdeenshire Scotland | 204011970001 | |||||||
| MIDDLETON, Sandra Elizabeth | Secretario designado | Investment House 6 Union Row AB9 8DQ Aberdeen | British | 900000270001 | ||||||
| WATSON, Christopher Edward Milne | Secretario | 77 Fountainhall Road AB15 4EA Aberdeen | British | 60315030001 | ||||||
| ANGUS, Grant Rae | Director | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | 197743170001 | |||||
| BAILLIE, David Charles | Director | Birchbank AB51 5JU Burnhervie Aberdeenshire | Great Britain | British | 89636000001 | |||||
| BRADWELL, Garth Jeffrey | Director | 5 Nightingale Croft Thorpe Hesley S61 2UB Rotherham South Yorkshire | British | 66587570001 | ||||||
| BROADLEY, Stuart Richard | Director | John Wood House, Greenwell Road East Tullos AB12 3AX Aberdeen | Scotland | British | 96818620001 | |||||
| CARR, William Hadden | Director | Collieston Hall AB41 8RS Collieston Aberdeenshire | British | 100270001 | ||||||
| CRAWFORD, James Duncan | Director | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | 169953750001 | |||||
| DAVENPORT, John Rowland | Director | Castle Street Castlepark Industrial Estate AB41 9RF Ellon Formartine House Scotland | England | British | 291715640001 | |||||
| DEWITZ, Philippe Andreas | Director | Castle Street Castlepark Industrial Estate AB41 9RF Ellon Formartine House Scotland | Switzerland | Swiss | 217097980001 | |||||
| DICKIE, Graham | Director | 12 Northburn Avenue AB15 6AH Aberdeen | British | 121618900001 | ||||||
| DOWLE, Keith | Director | 10 Smithies Lane S75 1BH Barnsley South Yorkshire | United Kingdom | British | 65271810001 | |||||
| DRON, Alexander | Director | Villafield Elrick AB32 6TJ Westhill Aberdeenshire | British | 63998700002 | ||||||
| EDGAR, William | Director | 3 Cairnie View Westhill AB32 6NB Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 109447840001 | |||||
| GILCHRIST, Thomas Armstrong | Director | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 | Scotland | British | 240837940001 | |||||
| HALL, Stuart | Director | Newlyn Huntly Road AB34 5HE Aboyne Aberdeenshire | British | 37727490001 | ||||||
| HODGSON, Andrew | Director | The Poplars Church Lane Averham NG23 5RB Newark Nottinghamshire | British | 109391270001 | ||||||
| JESSIMAN, Scott | Director | John Wood House, Greenwell Road East Tullos AB12 3AX Aberdeen | Scotland | British | 181632620001 | |||||
| JOHNSTONE, Alan James | Director | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 | Scotland | British | 108475490001 | |||||
| JONES, Wayne | Director | 4 Highbury Road Heaton Chapel SK4 5AZ Stockport Cheshire | British | 98176940001 | ||||||
| JUKES, Robert Arthur | Director | 46 Springwater Avenue Holcombe Brook BL0 9TX Bury Lancashire | British | 41727360001 | ||||||
| LANGLANDS, Allister Gordon | Director | Craigentoul 16 Hillhead Road, Bieldside AB15 9EJ Aberdeen | Scotland | British | 34145910003 | |||||
| LITTLE, John | Director | 6 Riverside Park Port Elphinstone AB51 3SB Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 106011130001 | |||||
| MCNIVEN, Alan Ross | Director designado | Investment House 6 Union Row AB9 8DQ Aberdeen | British | 900000280001 | ||||||
| MURRAY, Iain | Director | John Wood House, Greenwell Road East Tullos AB12 3AX Aberdeen | Usa | British | 155887240001 | |||||
| NADKARNI, Subodh Satchitanand | Director | Castle Street Castlepark Industrial Estate AB41 9RF Ellon Sulzer Wood Limited Aberdeenshire Scotland | Netherlands | Indian | 183995950001 | |||||
| NICOL, Stephen James | Director | John Wood House, Greenwell Road East Tullos AB12 3AX Aberdeen | Scotland | British | 162632260012 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SULZER (ABERDEEN) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood Group Engineering & Operations Support Limited | 06 abr 2016 | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Sulzer (Uk) Holdings Limited | 06 abr 2016 | Manor Mill Lane LS11 8BR Leeds Manor Mill Lane West Yorkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0