LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC148063 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Citypoint, 65 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| UBERIOR NOMINEES (SWIFT B.P.U.T.) LIMITED | 10 dic 1993 | 10 dic 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Cbre Global Investors (Uk) Limited el 07 oct 2021 | 1 páginas | CH04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Robert Peter Morgan como director el 27 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Sadish Kumar como director el 08 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Robert Peter Morgan como director el 30 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Christopher Daggett como director el 30 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Roderick Dale-Harris como director el 30 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Secretario corporativo | One New Change EC4M 9AF London Third Floor United Kingdom |
| 98655040005 | ||||||||||
| KUMAR, Sadish | Director | Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Citypoint, 65 | United Kingdom | British | 271843470001 | |||||||||
| MAKELE, Ahmed Remi | Director | Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Citypoint, 65 Scotland | England | British | 92800810001 | |||||||||
| ANDERSON, Richard Alexander | Secretario | 48 West Square SE11 4SP London | British | 44190890002 | ||||||||||
| ATTLEY, Denise Roberta | Secretario | 36 Scollon Avenue EH19 3QB Bonnyrigg Midlothian | British | 2805770001 | ||||||||||
| BLACK, Lysanne Jane Warren | Secretario | 6 Belgrave Crescent EH4 3AQ Edinburgh | British | 46707740002 | ||||||||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Secretario | 25 Belford Gardens EH4 3EP Edinburgh Midlothian | British | 34800860001 | ||||||||||
| BUCHAN, Ozgul Mehmet | Secretario | 6 Aldergrove Walk Airfield Way RM12 6NT Hornchurch Essex | British | 4489450001 | ||||||||||
| CAMERON, Helen Joan | Secretario | 15 Stanley Road SM2 6TB Sutton Surrey | British | 66097400001 | ||||||||||
| CAPELLOS, Stella | Secretario | 56 Runnymede Gardens Western Avenue UB6 8SU Greenford Middlesex | British | 49947490001 | ||||||||||
| COLE, Stephanie Margaret | Secretario | 77 Roxy Avenue Chadwell Heath RM6 4AZ Romford Essex | British | 37213640001 | ||||||||||
| DONALD, Carole Ann | Secretario | 30 Kipling Court Greenford Avenue Hanwell W7 1LZ London | British | 39357600001 | ||||||||||
| FARNHAM, Lorraine Susan | Secretario | 45 Selby Road Plaistow E13 8NB London | British | 46255900003 | ||||||||||
| FORBES, Arlene | Secretario | 25 Tollgate Drive Stanway CO3 5PE Colchester Essex | British | 46196430001 | ||||||||||
| GALLEY, Marian | Secretario | 105 Farningham Road CR3 6LN Caterham Surrey England | British | 48231490001 | ||||||||||
| GAY, Gary Mclean | Secretario | Gladesdale Glenmore Road East TN6 1RE Crowborough East Sussex | British | 598780002 | ||||||||||
| GLANCY, June Wendy | Secretario | 708 Ferry Road EH4 4AH Edinburgh | British | 54861480001 | ||||||||||
| GLENDINNING, Sharron Louise | Secretario | 22 Bramble Road SS9 5HB Leigh On Sea Essex | British | 67674210001 | ||||||||||
| GOLDSMITH, Kim | Secretario | 23 Lime Court 33 Trinity Close E11 4RX London | British | 48234020001 | ||||||||||
| HARRIS, Ian Robert | Secretario | 80 Oxlow Lane RM9 5XD Dagenham Essex | British | 46256570001 | ||||||||||
| HAYWARD, Susan Teresa | Secretario | 48 Rothbury Avenue RM13 9HZ Rainham Essex | British | 55056390001 | ||||||||||
| HENDRY, Laurence John | Secretario | 33 Chessington Avenue DA7 5NN Bexley Heath Kent | British | 598770001 | ||||||||||
| HENDRY, Laurence John | Secretario | 33 Chessington Avenue DA7 5NN Bexley Heath Kent | British | 598770001 | ||||||||||
| HUNTER, John Stewart | Secretario | 27 Queens Crescent EH9 2BA Edinburgh | British | 1127070001 | ||||||||||
| IMRIE, Steven William | Secretario | 32 Easter Hermitage EH6 8DR Edinburgh | British | 48235790002 | ||||||||||
| JAMIESON, Irene Margaret | Secretario | 24 Allanpark Crescnet EH14 1LF Edinburgh Midlothian | British | 110811990001 | ||||||||||
| JOHNSTON, Allan Farquhar | Secretario | 6 Folly Pathway WD7 8DS Radlett Hertfordshire | British | 43144320001 | ||||||||||
| JONES, Arthur Philip Warriner | Secretario | Weyhill Crown Heights GU1 3TX Guildford Surrey | British | 47070070001 | ||||||||||
| KING, Thomas Francis Hazell | Secretario | 61 Beechwood Road CR2 0AE South Croydon Surrey | British | 82582620001 | ||||||||||
| LYALL, James Ross | Secretario | 7 Oxford Terrace EH4 1PX Edinburgh Midlothian | British | 64326010001 | ||||||||||
| MCLEAN, Robin Kean | Secretario | 7 Bredon Road RG41 1HW Wokingham Berkshire | British | 54845850001 | ||||||||||
| O'HARE, Kevin Patrick | Secretario | 43 Cromwell Road Acton W3 6BN London | British | 31151870001 | ||||||||||
| PIERCE, Lesley Anne Frances | Secretario | 20 Bush Hall Road CM12 0PU Billericay Essex | British | 44196070001 | ||||||||||
| PRYDE, Catherine Joyce | Secretario | 12 Netherbank EH16 6YR Edinburgh | British | 47717750001 | ||||||||||
| RAWLINGS, Julie | Secretario | 2 Herald Walk DA1 5SS Dartford Kent | British | 49946420001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cbre Uk Property Fund (General Partner) Limited | 06 abr 2016 | One New Change EC4M 9AF London Third Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 29 sept 2006 Entregado el 10 oct 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due under the finance documents | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 may 1999 Entregado el 25 may 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 268-282 waterloo road, london. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 may 1999 Entregado el 25 may 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 14 headgate, colchester. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 24 nov 1998 Entregado el 08 dic 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 14 headgate,colchester. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 24 nov 1998 Entregado el 08 dic 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 268-282 waterloo road,london. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 01 jul 1997 Entregado el 08 jul 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The deferred consideration under an agreement | |
Breve descripción The freehold property known as 61 east street taunton as compried in title number ST117541 at hm land registry and the leasehold property known as land and buildings on the north side of colonial way watford comprised in title number HO287263 at hm land registry. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 mar 1995 Entregado el 13 mar 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due and to become due by the governor and company of the bank of scotland | |
Breve descripción 14 headgate, colchester, essex, registered under title number ex 505255. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0