LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED

LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC148063
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    • Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Citypoint, 65 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UBERIOR NOMINEES (SWIFT B.P.U.T.) LIMITED10 dic 199310 dic 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Cbre Global Investors (Uk) Limited el 07 oct 2021

    1 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Robert Peter Morgan como director el 27 jul 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Sadish Kumar como director el 08 jul 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Robert Peter Morgan como director el 30 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Christopher Daggett como director el 30 abr 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan Roderick Dale-Harris como director el 30 abr 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CBRE INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro1232680
    98655040005
    KUMAR, Sadish
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    Director
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    United KingdomBritish271843470001
    MAKELE, Ahmed Remi
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    Scotland
    Director
    Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Citypoint, 65
    Scotland
    EnglandBritish92800810001
    ANDERSON, Richard Alexander
    48 West Square
    SE11 4SP London
    Secretario
    48 West Square
    SE11 4SP London
    British44190890002
    ATTLEY, Denise Roberta
    36 Scollon Avenue
    EH19 3QB Bonnyrigg
    Midlothian
    Secretario
    36 Scollon Avenue
    EH19 3QB Bonnyrigg
    Midlothian
    British2805770001
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Secretario
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOTHWELL, Karen Margaret
    25 Belford Gardens
    EH4 3EP Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    25 Belford Gardens
    EH4 3EP Edinburgh
    Midlothian
    British34800860001
    BUCHAN, Ozgul Mehmet
    6 Aldergrove Walk
    Airfield Way
    RM12 6NT Hornchurch
    Essex
    Secretario
    6 Aldergrove Walk
    Airfield Way
    RM12 6NT Hornchurch
    Essex
    British4489450001
    CAMERON, Helen Joan
    15 Stanley Road
    SM2 6TB Sutton
    Surrey
    Secretario
    15 Stanley Road
    SM2 6TB Sutton
    Surrey
    British66097400001
    CAPELLOS, Stella
    56 Runnymede Gardens
    Western Avenue
    UB6 8SU Greenford
    Middlesex
    Secretario
    56 Runnymede Gardens
    Western Avenue
    UB6 8SU Greenford
    Middlesex
    British49947490001
    COLE, Stephanie Margaret
    77 Roxy Avenue
    Chadwell Heath
    RM6 4AZ Romford
    Essex
    Secretario
    77 Roxy Avenue
    Chadwell Heath
    RM6 4AZ Romford
    Essex
    British37213640001
    DONALD, Carole Ann
    30 Kipling Court
    Greenford Avenue Hanwell
    W7 1LZ London
    Secretario
    30 Kipling Court
    Greenford Avenue Hanwell
    W7 1LZ London
    British39357600001
    FARNHAM, Lorraine Susan
    45 Selby Road
    Plaistow
    E13 8NB London
    Secretario
    45 Selby Road
    Plaistow
    E13 8NB London
    British46255900003
    FORBES, Arlene
    25 Tollgate Drive
    Stanway
    CO3 5PE Colchester
    Essex
    Secretario
    25 Tollgate Drive
    Stanway
    CO3 5PE Colchester
    Essex
    British46196430001
    GALLEY, Marian
    105 Farningham Road
    CR3 6LN Caterham
    Surrey
    England
    Secretario
    105 Farningham Road
    CR3 6LN Caterham
    Surrey
    England
    British48231490001
    GAY, Gary Mclean
    Gladesdale
    Glenmore Road East
    TN6 1RE Crowborough
    East Sussex
    Secretario
    Gladesdale
    Glenmore Road East
    TN6 1RE Crowborough
    East Sussex
    British598780002
    GLANCY, June Wendy
    708 Ferry Road
    EH4 4AH Edinburgh
    Secretario
    708 Ferry Road
    EH4 4AH Edinburgh
    British54861480001
    GLENDINNING, Sharron Louise
    22 Bramble Road
    SS9 5HB Leigh On Sea
    Essex
    Secretario
    22 Bramble Road
    SS9 5HB Leigh On Sea
    Essex
    British67674210001
    GOLDSMITH, Kim
    23 Lime Court 33 Trinity Close
    E11 4RX London
    Secretario
    23 Lime Court 33 Trinity Close
    E11 4RX London
    British48234020001
    HARRIS, Ian Robert
    80 Oxlow Lane
    RM9 5XD Dagenham
    Essex
    Secretario
    80 Oxlow Lane
    RM9 5XD Dagenham
    Essex
    British46256570001
    HAYWARD, Susan Teresa
    48 Rothbury Avenue
    RM13 9HZ Rainham
    Essex
    Secretario
    48 Rothbury Avenue
    RM13 9HZ Rainham
    Essex
    British55056390001
    HENDRY, Laurence John
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    Secretario
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    British598770001
    HENDRY, Laurence John
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    Secretario
    33 Chessington Avenue
    DA7 5NN Bexley Heath
    Kent
    British598770001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Secretario
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    British1127070001
    IMRIE, Steven William
    32 Easter Hermitage
    EH6 8DR Edinburgh
    Secretario
    32 Easter Hermitage
    EH6 8DR Edinburgh
    British48235790002
    JAMIESON, Irene Margaret
    24 Allanpark Crescnet
    EH14 1LF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    24 Allanpark Crescnet
    EH14 1LF Edinburgh
    Midlothian
    British110811990001
    JOHNSTON, Allan Farquhar
    6 Folly Pathway
    WD7 8DS Radlett
    Hertfordshire
    Secretario
    6 Folly Pathway
    WD7 8DS Radlett
    Hertfordshire
    British43144320001
    JONES, Arthur Philip Warriner
    Weyhill
    Crown Heights
    GU1 3TX Guildford
    Surrey
    Secretario
    Weyhill
    Crown Heights
    GU1 3TX Guildford
    Surrey
    British47070070001
    KING, Thomas Francis Hazell
    61 Beechwood Road
    CR2 0AE South Croydon
    Surrey
    Secretario
    61 Beechwood Road
    CR2 0AE South Croydon
    Surrey
    British82582620001
    LYALL, James Ross
    7 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    7 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Midlothian
    British64326010001
    MCLEAN, Robin Kean
    7 Bredon Road
    RG41 1HW Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    7 Bredon Road
    RG41 1HW Wokingham
    Berkshire
    British54845850001
    O'HARE, Kevin Patrick
    43 Cromwell Road
    Acton
    W3 6BN London
    Secretario
    43 Cromwell Road
    Acton
    W3 6BN London
    British31151870001
    PIERCE, Lesley Anne Frances
    20 Bush Hall Road
    CM12 0PU Billericay
    Essex
    Secretario
    20 Bush Hall Road
    CM12 0PU Billericay
    Essex
    British44196070001
    PRYDE, Catherine Joyce
    12 Netherbank
    EH16 6YR Edinburgh
    Secretario
    12 Netherbank
    EH16 6YR Edinburgh
    British47717750001
    RAWLINGS, Julie
    2 Herald Walk
    DA1 5SS Dartford
    Kent
    Secretario
    2 Herald Walk
    DA1 5SS Dartford
    Kent
    British49946420001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cbre Uk Property Fund (General Partner) Limited
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    England
    06 abr 2016
    One New Change
    EC4M 9AF London
    Third Floor
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House, London
    Número de registro03377515
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene LIONBROOK PROPERTY PARTNERSHIP NOMINEE NO 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 29 sept 2006
    Entregado el 10 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the finance documents
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Trustee and Agent
    Transacciones
    • 10 oct 2006Registro de un cargo (410)
    • 13 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 24 may 1999
    Entregado el 25 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    268-282 waterloo road, london.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 may 1999Registro de un cargo (410)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 24 may 1999
    Entregado el 25 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    14 headgate, colchester.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 may 1999Registro de un cargo (410)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 24 nov 1998
    Entregado el 08 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    14 headgate,colchester.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 dic 1998Registro de un cargo (410)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 24 nov 1998
    Entregado el 08 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    268-282 waterloo road,london.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 dic 1998Registro de un cargo (410)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1997
    Entregado el 08 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration under an agreement
    Breve descripción
    The freehold property known as 61 east street taunton as compried in title number ST117541 at hm land registry and the leasehold property known as land and buildings on the north side of colonial way watford comprised in title number HO287263 at hm land registry.
    Personas con derecho
    • The Henry Moore Foundation
    Transacciones
    • 08 jul 1997Registro de un cargo (410)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 08 mar 1995
    Entregado el 13 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due and to become due by the governor and company of the bank of scotland
    Breve descripción
    14 headgate, colchester, essex, registered under title number ex 505255.
    Personas con derecho
    • Banque Indosuez
    Transacciones
    • 13 mar 1995Registro de un cargo (410)
    • 22 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0