ACERGY EQUIPMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ACERGY EQUIPMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC148981 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | East Campus Prospect Road, Arnhall Business Park AB32 6FE Westhill Aberdeenshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CAN-DIVE MARINE U.K. LIMITED | 16 dic 1994 | 16 dic 1994 |
| LEDGE 189 LIMITED | 10 feb 1994 | 10 feb 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary George Gray como director el 24 jul 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 feb 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Stephen Anthony Mcneill como director el 30 sept 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Lorna Helen Peace como secretario el 30 sept 2013 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary George Gray como secretario el 30 sept 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gael Jean Marie Cailleaux como director el 30 sept 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 feb 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Acergy M.S. Limited el 12 ene 2011 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 nov 2011 au 31 dic 2011 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Alexander Gordon como director el 26 mar 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Evan Hislop como director el 26 mar 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 feb 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Subsea7 Campus West Tarland Road Skene Westhill Aberdeenshire AB32 6JZ Scotland el 20 dic 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 feb 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Acergy Campus Tarland Road Westhill Aberdeen Aberdeenshire AB32 6JZ United Kingdom el 19 may 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2010 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2009 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 feb 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Acergy M.S. Limited el 30 oct 2009 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Welsh como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ACERGY EQUIPMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEACE, Lorna Helen | Secretario | Prospect Road, Arnhall Business Park AB32 6FE Westhill East Campus Aberdeenshire Scotland | 183436370001 | |||||||||||
| SUBSEA 7 M.S. LIMITED | Secretario corporativo | Hammersmith Road Hammersmith W6 7DL London 200 United Kingdom |
| 74739410006 | ||||||||||
| GORDON, John Alexander | Director | Prospect Road, Arnhall Business Park AB32 6FE Westhill East Campus Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | 160747950001 | |||||||||
| MCNEILL, Stephen Anthony | Director | Prospect Road, Arnhall Business Park AB32 6FE Westhill East Campus Aberdeenshire Scotland | United Kingdom | British | 181406320001 | |||||||||
| GRAY, Gary George | Secretario | 7 Overton Park Dyce AB21 7FT Aberdeen Aberdeenshire | British | 102140060001 | ||||||||||
| IRVINE, Hugh Richard | Secretario | Spottiswoode Street EH9 1DJ Edinburgh 92(1f1) | British | 126753010002 | ||||||||||
| REKVE, Ellen Norloff | Secretario | Marknes Ringen 6 4052 Royneberg Norway | Norwegian | 127568630001 | ||||||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Secretario designado corporativo | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen | 900003330001 | |||||||||||
| CAHUZAC, Jean Paul | Director | Chiddingstone Street SW6 3TG London 28 | United Kingdom | French | 130166250003 | |||||||||
| CAILLEAUX, Gael Jean Marie | Director | Prospect Road, Arnhall Business Park AB32 6FE Westhill East Campus Aberdeenshire Scotland | France | French | 149415610001 | |||||||||
| CROWE, Simon Paul | Director | Tarland Road Westhill AB32 6JZ Aberdeen Acergy Campus Aberdeenshire United Kingdom | England | British | 187978480002 | |||||||||
| EHRET, Thomas | Director | 601 Sovereign Court 29 Wrights Lane, Kensington W8 5SH London | French | 88979570001 | ||||||||||
| GRAY, Gary George | Director | 7 Overton Park Dyce AB21 7FT Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 102140060001 | |||||||||
| HEBERT, Quinn Joseph | Director | 900 Town & Country Lane Suite 400 77024 Houston Texas Usa | American | 55494190001 | ||||||||||
| HISLOP, Dean Evan | Director | Prospect Road, Arnhall Business Park AB32 6FE Westhill East Campus Aberdeenshire Scotland | United Kingdom | British | 186016900001 | |||||||||
| JACKSON, Stuart Robert | Director | Lower Farm Bury Green SG11 2EY Little Hadham Hertfordshire | United Kingdom | British | 110858010001 | |||||||||
| JONES, Mike John, Dr | Director | Norman Avenue TW1 2LY Twickenham 9 Middlesex | British | 140334700001 | ||||||||||
| LEATT, Allen Frederick | Director | Flat 55 York Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4BP London | United Kingdom | British | 106314440001 | |||||||||
| LEITH, Brian Forbes | Director | 35 Polmuir Gardens AB11 7WE Aberdeen Aberdeenshire | Uk | Uk | 79052310002 | |||||||||
| MCNEILL, Johnston | Director | Shaw Crescent Elm Hill AB25 3BU Aberdeen 134 Aberdeenshire | British | 135011280001 | ||||||||||
| NUYTETEN, Rene Theophil | Director | 4032 Glenview Cres V7R 3GN North Vancouver Canada | Canadian | 42334540001 | ||||||||||
| PREECE, Mark Alfred | Director | Flood Lane TW1 3NY Twickenham 6 Middx | United Kingdom | British | 197552490003 | |||||||||
| WELSH, Thomas Gibson | Director | Dinnet AB34 5LL Aboyne The Auld Kirk Aberdeenshire | United Kingdom | British | 140426620001 | |||||||||
| WEST, Alan William Henry | Director | 26 Harlaw Road AB15 4YY Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | Irish | 81154990002 | |||||||||
| DURANO LIMITED | Director designado corporativo | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen | 900003320001 |
¿Tiene ACERGY EQUIPMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Receivables assignment | Creado el 08 nov 2004 Entregado el 29 nov 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due in respect of the secured bilateral bond obligations | |
Breve descripción The company's right, title, interest and benefit pursuant to the monies payable under each of the contracts other than the excluded contract and the statoil contract. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Receivables assignment | Creado el 08 nov 2004 Entregado el 20 nov 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The company's right, title and interest and benefit in and to any charter-out contracts, agreements or other agreements in relation to any vessel. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0