TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED

TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC150058
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TELEWEST SCOTLAND HOLDINGS LIMITED22 abr 199422 abr 1994
    RUBYSUDDEN LIMITED07 abr 199407 abr 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Nombramiento de Mr Roderick Gregor Mcneil como director el 09 mar 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de William Thomas Castell como director el 09 mar 2020

    1 páginasTM01

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    9 páginasLIQ13(Scot)

    Nombramiento de Mr William Thomas Castell como director el 09 sept 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Dominic Dunn como director el 09 sept 2019

    1 páginasTM01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 1 South Gyle Crescent Street Edinburgh EH3 8EX

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 1 South Gyle Crescent Street Edinburgh EH3 8EX

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX el 22 jul 2019

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 09 jul 2019

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 31 ago 2018

    • Capital: GBP 1.00
    1 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2017

    17 páginasAA

    legacy

    80 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    legacy

    80 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    85 páginasPARENT_ACC

    ¿Quiénes son los directivos de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Secretario
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    151396040001
    HIFZI, Mine Ozkan
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Director
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish182167230001
    MCNEIL, Roderick Gregor
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish267964620001
    BROADEST, Guy David
    Tile House
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Secretario
    Tile House
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    British96454660001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secretario
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Secretario
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secretario
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    WRIGHT, Tina Alison
    7168 S. Niagara Court
    80112 Englewood
    Colorado
    United States Of America
    Secretario
    7168 S. Niagara Court
    80112 Englewood
    Colorado
    United States Of America
    British38915690001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secretario corporativo
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRYAN, Danny Frank
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Director
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    American41071470001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Director
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CARLETON, Lawrence James
    The Marble Suite
    The Mansion,Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Director
    The Marble Suite
    The Mansion,Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    British38914530001
    CASTELL, William Thomas
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Director
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    DUNN, Robert Dominic
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Director
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Director
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    EnglandBritish96956740001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Director
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Director
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MICHELS, Alan
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    Director
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    British43658810001
    REXROTH, Lynn Charles
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Director
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    American49075080001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Director
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Director
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Director
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Director
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Director
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Director
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish140137570002
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Director designado corporativo
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Director designado corporativo
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Director corporativo
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Director corporativo
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3291383
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite debenture
    Creado el 29 jun 2010
    Entregado el 09 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 09 jul 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 08 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Confirmation deed
    Creado el 15 abr 2010
    Entregado el 30 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 30 abr 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 30 abr 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 08 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Confirmation deed
    Creado el 15 abr 2010
    Entregado el 30 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 30 abr 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 30 abr 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 08 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 19 ene 2010
    Entregado el 08 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 08 feb 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 01 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Composite debenture
    Creado el 19 ene 2010
    Entregado el 02 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 02 feb 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 17 sept 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Shares pledge
    Creado el 19 ene 2010
    Entregado el 29 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Right title interest and benefit in pledged securities.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 29 ene 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 01 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Composite debenture
    Creado el 19 ene 2010
    Entregado el 28 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 28 ene 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 28 ene 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 30 abr 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 08 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 19 ene 2010
    Entregado el 28 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 28 ene 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 28 ene 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 30 abr 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 09 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Shares pledge
    Creado el 19 ene 2010
    Entregado el 27 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Rights title interest and benefit in pledged securities.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 27 ene 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 01 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Floating charge
    Creado el 03 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (410)
    • 22 mar 2006Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 27 ene 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 01 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 03 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 22 mar 2006Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (410)
    • 15 ene 2010Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 01 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 21 dic 2004
    Entregado el 07 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 07 ene 2005Registro de un cargo (410)
    • 10 ene 2005Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 05 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 21 dic 2004
    Entregado el 07 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 07 ene 2005Registro de un cargo (410)
    • 10 ene 2005Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 05 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 14 jul 2004
    Entregado el 30 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal charges over properties (see mortgage document for full listings); fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 30 jul 2004Registro de un cargo (410)
    • 10 ene 2005Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 mar 2006Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 19 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 14 jul 2004
    Entregado el 30 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 30 jul 2004Registro de un cargo (410)
    • 10 ene 2005Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 mar 2006Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 19 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 16 mar 2001
    Entregado el 02 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 02 abr 2001Registro de un cargo (410)
    • 10 ene 2005Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 mar 2006Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 19 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 20 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 05 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Share pledge agreement
    Creado el 15 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Pledged securities as defined in ch microfiche.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 17 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 15 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (410)
    • 05 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 26 sept 1998
    Entregado el 13 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Toronto-Dominion Bank as Security Trustee
    Transacciones
    • 13 oct 1998Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 24 jul 1996
    Entregado el 09 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    Fixed and floating charges on various assets....... See ch microfiche for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc Wood Gundy PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transacciones
    • 09 ago 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 24 jul 1996
    Entregado el 08 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    All property etc....... see ch microfiche for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cibc Wood Gundy PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transacciones
    • 08 ago 1996Registro de un cargo (410)
    • 30 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 13 jun 1994
    Entregado el 27 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descripción
    Fixed and floating charge see ch microfiche.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Trustee
    Transacciones
    • 27 jun 1994Registro de un cargo (410)
    • 19 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 13 jun 1994
    Entregado el 27 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Trustee
    Transacciones
    • 27 jun 1994Registro de un cargo (410)
    • 19 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene TELEWEST COMMUNICATIONS (SCOTLAND HOLDINGS) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 jul 2019Inicio de la liquidación
    10 may 2020Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0