MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED

MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC151333
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Rutland Court
    Edinburgh
    EH3 8EY
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KENMORE NORTHERN LIMITED15 jun 199515 jun 1995
    KENMORE (NEWCASTLE) LIMITED08 jul 199408 jul 1994
    JADEDELL LIMITED09 jun 199409 jun 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jul 2013

    Estado de capital el 18 jul 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2012

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Dr Mark Whitworth el 09 may 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Dr Mark Whitworth como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alan Barr como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2010

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Thomas Eardley Allison como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Baxter como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2009

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Stephen Roy Baxter el 25 nov 2009

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Caroline Ruth Marrison Gill como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Bowley como secretario

    1 páginasTM02

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2008

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Secretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    British147011370001
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    United Kingdom
    Director
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish1037730004
    WHITTAKER, John
    Billown Mansion House
    Malew
    IM9 3DL Ballasalla
    Isle Of Man
    Director
    Billown Mansion House
    Malew
    IM9 3DL Ballasalla
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish1614010001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Secretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    CHIENE & TAIT
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Secretario corporativo
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    99191230001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Director
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Director
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    Director
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    ScotlandBritish86622660005
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Director
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Director
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish30045540003
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Director
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Director
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    KENNEDY, Patricia Alice
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    Director
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish168440970002
    KENNEDY, Patricia Alice
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    Director
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    British224880001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Director
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    THOMSON, William George Ritchie
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    British72331280001
    WHARTON, Kenneth John
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    Director
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    British9964160002
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Director
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    WILLIAMS, Thomas David
    23 Woodlands Road
    L37 2JN Formby
    Merseyside
    Director
    23 Woodlands Road
    L37 2JN Formby
    Merseyside
    British51662010001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Director designado corporativo
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    ¿Tiene MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 28 feb 2007
    Entregado el 08 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage, fixed charges, assignments and floating charge - see form 410 paper apart for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 12 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 feb 2007
    Entregado el 08 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 12 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Standard security
    Creado el 16 abr 1999
    Entregado el 21 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Unit 25, whistleberry road, whistleberry industrial estate, hamilton.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 abr 1999Registro de un cargo (410)
    • 19 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 15 ago 1995
    Entregado el 21 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Floating charge on all assets and fixed charge over property at commercial street, rothwell, leeds, registered under title number wyk 103921.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 ago 1995Registro de un cargo (410)
    • 24 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 01 jun 1995
    Entregado el 16 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 jun 1995Registro de un cargo (410)
    • 11 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0