MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC151333 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?
- Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KENMORE NORTHERN LIMITED | 15 jun 1995 | 15 jun 1995 |
| KENMORE (NEWCASTLE) LIMITED | 08 jul 1994 | 08 jul 1994 |
| JADEDELL LIMITED | 09 jun 1994 | 09 jun 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 jun 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Dr Mark Whitworth el 09 may 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Dr Mark Whitworth como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Barr como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2010 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Thomas Eardley Allison como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Baxter como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 09 jun 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2009 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Stephen Roy Baxter el 25 nov 2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Caroline Ruth Marrison Gill como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Bowley como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2008 | 10 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRISON GILL, Caroline Ruth | Secretario | 113 Tarvin Road Littleton CH3 7DE Chester Woodleigh Cheshire | British | 147011370001 | ||||||
| ALLISON, Thomas Eardley | Director | 23 Park Place FK7 9JR Stirling Rockdale Lodge Scotland United Kingdom | Scotland | British | 1037730004 | |||||
| WHITTAKER, John | Director | Billown Mansion House Malew IM9 3DL Ballasalla Isle Of Man | Isle Of Man | British | 1614010001 | |||||
| WHITWORTH, Mark | Director | Culvert Lane Off Back Lane WN8 7XA Newburgh Springside Lancashire United Kingdom | England | British | 120679580002 | |||||
| BOWLEY, William John | Secretario | 17 St Georges Road Formby L37 3HH Liverpool Merseyside | British | 4171240002 | ||||||
| BROWN, John Kenneth | Secretario | 40 Beech Avenue G77 5PP Glasgow Renfrewshire | British | 462890002 | ||||||
| CHIENE & TAIT | Secretario corporativo | 61 Dublin Street EH3 6NL Edinburgh | 99191230001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ALLISON, Thomas Eardley | Director | Rockdale Lodge 23 Park Place FK7 9JR Stirling Scotland | Scotland | British | 1037730004 | |||||
| BARR, Alan Andrew | Director | 7 Wellington Terrace ML11 7QQ Lanark Lanarkshire | Scotland | British | 121452150001 | |||||
| BAXTER, Stephen Roy | Director | Springkell Avenue Pollokshields G41 4EH Glasgow 94 | Scotland | British | 86622660005 | |||||
| BROWN, John Kenneth | Director | 40 Beech Avenue G77 5PP Glasgow Renfrewshire | Scotland | British | 462890002 | |||||
| FINDLAY, Alastair Ian | Director | High Billinge House Utkinton CW6 0LA Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 30045540003 | |||||
| GREEN, David Simon | Director | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | 42038120003 | ||||||
| KENNEDY, John Anthony Bingham | Director | Newhall Carlops EH26 9LY Penicuik Midlothian | Scotland | British | 71043680001 | |||||
| KENNEDY, Patricia Alice | Director | Newhall EH26 9LY Carlops Midlothian Scotland | Scotland | British | 168440970002 | |||||
| KENNEDY, Patricia Alice | Director | Hazlieburn EH46 7AS West Linton Peeblesshire | British | 224880001 | ||||||
| SCOTT, Peter Anthony | Director | 6 Bowling Green Way Bamford OL11 5QQ Rochdale Lancashire | British | 1674500002 | ||||||
| THOMSON, William George Ritchie | Director | 6 Oswald Road EH9 2HF Edinburgh Midlothian | British | 72331280001 | ||||||
| WHARTON, Kenneth John | Director | Cornercroft 7 Glendyke Road L18 6JR Liverpool Merseyside | British | 9964160002 | ||||||
| WHITE, Andrew Edward | Director | Craigend 2 Cromwell Road EH39 4LZ North Berwick East Lothian | Scotland | British | 110163980001 | |||||
| WILLIAMS, Thomas David | Director | 23 Woodlands Road L37 2JN Formby Merseyside | British | 51662010001 | ||||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Director designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
¿Tiene MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 28 feb 2007 Entregado el 08 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage, fixed charges, assignments and floating charge - see form 410 paper apart for full details. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 23 feb 2007 Entregado el 08 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 abr 1999 Entregado el 21 abr 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Unit 25, whistleberry road, whistleberry industrial estate, hamilton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 15 ago 1995 Entregado el 21 ago 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Floating charge on all assets and fixed charge over property at commercial street, rothwell, leeds, registered under title number wyk 103921. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 01 jun 1995 Entregado el 16 jun 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0