REVIVE MS SUPPORT

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREVIVE MS SUPPORT
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC152198
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REVIVE MS SUPPORT?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra REVIVE MS SUPPORT?

    Dirección de la sede social
    29 Dava Street Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REVIVE MS SUPPORT?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REVIVE SCOTLAND09 may 200109 may 2001
    MULTIPLE SCLEROSIS ACTION STRATHCLYDE28 jul 199428 jul 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REVIVE MS SUPPORT?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para REVIVE MS SUPPORT?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta14 ago 2025
    Próxima declaración de confirmación vence28 ago 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta14 ago 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REVIVE MS SUPPORT?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Catherine Mcgee como director el 21 may 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kirsten Ann Mctighe como director el 20 mar 2025

    1 páginasTM01

    Comptes modifiés pour une petite entreprise établis au 31 mar 2024

    36 páginasAAMD

    Memorándum y Estatutos

    17 páginasMA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    12 páginasAA

    Nombramiento de Ms Christine Hughes como director el 27 nov 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Lianne Mcinally como director el 21 ago 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 14 ago 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023

    38 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Catherine Barclay Symington como director el 11 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kirstin Rhona Coyle como director el 30 ago 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 ago 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Marion Buchart como director el 30 mar 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Kirsten Ann Mctighe como director el 26 oct 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Stuart como director el 24 ago 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    32 páginasAA

    Cese del nombramiento de Hilary Willamson Davison como director el 31 may 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Iain Morrison como secretario el 09 may 2022

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Iain Mcwhirter como secretario el 09 may 2022

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Elaine Green como director el 12 ene 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daniel Lafferty como director el 11 ene 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Angela Mary Samson como director el 25 nov 2021

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de REVIVE MS SUPPORT?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCWHIRTER, Iain
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Secretario
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    295601670001
    CUNNINGHAM, Michael
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant83188690002
    HUGHES, Christine
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishRetired306022020001
    MCINALLY, Lianne
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishAllied Health Proffessionals Senior Manager326917650001
    RUSSELL, Alan John
    Langton Place
    Newton Mearns
    G77 6QZ Glasgow
    23
    Scotland
    Director
    Langton Place
    Newton Mearns
    G77 6QZ Glasgow
    23
    Scotland
    ScotlandBritishRetired240756210001
    SOMMERVILLE, Niall
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishPublic Affairs Manager259661150001
    SYMINGTON, Catherine Barclay
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishOccupational Therapist227627240001
    DORNAN, James
    Bellshaugh Gardens
    G12 0SA Glasgow
    49g
    Secretario
    Bellshaugh Gardens
    G12 0SA Glasgow
    49g
    British135194280001
    MACLELLAN, Robin James
    14 Michael Mcparland Drive
    Torrance
    G64 4EE Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    14 Michael Mcparland Drive
    Torrance
    G64 4EE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChief Executive107132710002
    MORRISON, Iain
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Secretario
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    172208090001
    MURRAY, Isabel
    22 Pollock Road
    Bearsden
    G61 2NJ Glasgow
    Secretario
    22 Pollock Road
    Bearsden
    G61 2NJ Glasgow
    BritishRetired Nurse82320620001
    NEILL, Margaret Paterson
    38 Gilmour Drive
    ML3 9UQ Hamilton
    Lanarkshire
    Secretario
    38 Gilmour Drive
    ML3 9UQ Hamilton
    Lanarkshire
    BritishChief Executive34879360001
    TURNER, Brian
    89 St Andrews Drive
    PA11 3JD Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Secretario
    89 St Andrews Drive
    PA11 3JD Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    BritishEngineering Consultant1418480001
    WALLACE, Bruce
    23 Fairfield Drive
    Inchlea
    PA4 0EG Renfrew
    Secretario
    23 Fairfield Drive
    Inchlea
    PA4 0EG Renfrew
    BritishRetired Bank Manager1418510002
    BENNIE, William Allan
    5 Dougalston Gardens North
    Milngavie
    G62 6HL Glasgow
    Director
    5 Dougalston Gardens North
    Milngavie
    G62 6HL Glasgow
    BritishSafety Consultant39738520001
    BEST, Lesley Ann
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29
    Scotland
    ScotlandBritishBookkeeper245782990001
    BOYLE, John Anthony
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    Director
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    ScotlandBritishDirector124238380002
    BUCHART, Marion
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandScottishGovernment Affairs Manager280949280001
    COYLE, Kirstin Rhona
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29
    Scotland
    ScotlandBritishProject Manager252254740002
    DAVISON, Hilary Williamson
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishHealth & Wellbeing Consultant214733430001
    DICKSON, Ian
    7 Romney Avenue
    G44 5AW Glasgow
    Director
    7 Romney Avenue
    G44 5AW Glasgow
    ScotlandBritishRetired153780002
    DRUMMOND, Susan Allison
    Kirkcaldy Road
    G41 4LD Glasgow
    12, 80
    Scotland
    Director
    Kirkcaldy Road
    G41 4LD Glasgow
    12, 80
    Scotland
    ScotlandBritishOperations Manager203640180001
    GILL, Brendan James
    3a Sherbrooke Drive
    Pollokshields
    G41 5AA Glasgow
    Flat 2/2
    Director
    3a Sherbrooke Drive
    Pollokshields
    G41 5AA Glasgow
    Flat 2/2
    BritishAccountant (Retired)112278900002
    GREEN, Elaine
    Chapel Street Industrial Estate
    G20 9BQ Glasgow
    Revive Ms Support
    Scotland
    Director
    Chapel Street Industrial Estate
    G20 9BQ Glasgow
    Revive Ms Support
    Scotland
    ScotlandBritishRetired214823820001
    HAMILTON, Kimberley Anne
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandBritishPr Manager157375790001
    HODGSON, Irving
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    Director
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    ScotlandBritishRetired134760480001
    JONES, Derek
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    Director
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    ScotlandBritishExecutive Director49108710001
    KYLE, John Andrew
    50 Lubnaig Road
    Newlands
    G43 2RX Glasgow
    Director
    50 Lubnaig Road
    Newlands
    G43 2RX Glasgow
    ScotlandBritishSolicitor60270240001
    LAFFERTY, Daniel
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandScottishStrategy & Engagement Officer281324400001
    LININGTON, Christopher, Professor
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    Director
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    ScotlandBritishUniversity Professor160718390001
    MACKAY, Neil Sinclair Davis, Dr
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    Director
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    United KingdomBritishMedical Practitioner112278860001
    MCCORMICK, Patrick Kelly
    Capelrig Gardens
    Newton Mearns
    G77 6NF Glasgow
    Flat G1, 1
    Scotland
    Director
    Capelrig Gardens
    Newton Mearns
    G77 6NF Glasgow
    Flat G1, 1
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant206611890001
    MCGEE, Catherine
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    Director
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    29 Dava Street
    Scotland
    ScotlandScottishSpeech And Language Therapist250139840001
    MCINALLY, Thomas
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    Director
    Chapel Street Estate
    Maryhill
    G20 9BQ Glasgow
    Unit 16
    United KingdomBritishRetired Police Inspector149885260001
    MCLAUGHLIN, Lucille
    Douglas Gardens
    Giffnock
    G46 6NY Glasgow
    7
    Scotland
    Director
    Douglas Gardens
    Giffnock
    G46 6NY Glasgow
    7
    Scotland
    ScotlandBritishRetired193326690001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para REVIVE MS SUPPORT?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    04 ago 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0