REVIVE MS SUPPORT
Visión general
Nombre de la empresa | REVIVE MS SUPPORT |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
Número de empresa | SC152198 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de REVIVE MS SUPPORT?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra REVIVE MS SUPPORT?
Dirección de la sede social | 29 Dava Street Dava Street G51 2JA Glasgow Scotland |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REVIVE MS SUPPORT?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
REVIVE SCOTLAND | 09 may 2001 | 09 may 2001 |
MULTIPLE SCLEROSIS ACTION STRATHCLYDE | 28 jul 1994 | 28 jul 1994 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de REVIVE MS SUPPORT?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para REVIVE MS SUPPORT?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 ago 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 28 ago 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 ago 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para REVIVE MS SUPPORT?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Catherine Mcgee como director el 21 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kirsten Ann Mctighe como director el 20 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Comptes modifiés pour une petite entreprise établis au 31 mar 2024 | 36 páginas | AAMD | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 17 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Christine Hughes como director el 27 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Lianne Mcinally como director el 21 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 38 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Catherine Barclay Symington como director el 11 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kirstin Rhona Coyle como director el 30 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marion Buchart como director el 30 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Kirsten Ann Mctighe como director el 26 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Stuart como director el 24 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hilary Willamson Davison como director el 31 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Iain Morrison como secretario el 09 may 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Iain Mcwhirter como secretario el 09 may 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elaine Green como director el 12 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Lafferty como director el 11 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Mary Samson como director el 25 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de REVIVE MS SUPPORT?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCWHIRTER, Iain | Secretario | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | 295601670001 | |||||||
CUNNINGHAM, Michael | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Accountant | 83188690002 | ||||
HUGHES, Christine | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Retired | 306022020001 | ||||
MCINALLY, Lianne | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Allied Health Proffessionals Senior Manager | 326917650001 | ||||
RUSSELL, Alan John | Director | Langton Place Newton Mearns G77 6QZ Glasgow 23 Scotland | Scotland | British | Retired | 240756210001 | ||||
SOMMERVILLE, Niall | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Public Affairs Manager | 259661150001 | ||||
SYMINGTON, Catherine Barclay | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Occupational Therapist | 227627240001 | ||||
DORNAN, James | Secretario | Bellshaugh Gardens G12 0SA Glasgow 49g | British | 135194280001 | ||||||
MACLELLAN, Robin James | Secretario | 14 Michael Mcparland Drive Torrance G64 4EE Glasgow Lanarkshire | British | Chief Executive | 107132710002 | |||||
MORRISON, Iain | Secretario | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | 172208090001 | |||||||
MURRAY, Isabel | Secretario | 22 Pollock Road Bearsden G61 2NJ Glasgow | British | Retired Nurse | 82320620001 | |||||
NEILL, Margaret Paterson | Secretario | 38 Gilmour Drive ML3 9UQ Hamilton Lanarkshire | British | Chief Executive | 34879360001 | |||||
TURNER, Brian | Secretario | 89 St Andrews Drive PA11 3JD Bridge Of Weir Renfrewshire | British | Engineering Consultant | 1418480001 | |||||
WALLACE, Bruce | Secretario | 23 Fairfield Drive Inchlea PA4 0EG Renfrew | British | Retired Bank Manager | 1418510002 | |||||
BENNIE, William Allan | Director | 5 Dougalston Gardens North Milngavie G62 6HL Glasgow | British | Safety Consultant | 39738520001 | |||||
BEST, Lesley Ann | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Scotland | Scotland | British | Bookkeeper | 245782990001 | ||||
BOYLE, John Anthony | Director | Chapel Street Estate Maryhill G20 9BQ Glasgow Unit 16 | Scotland | British | Director | 124238380002 | ||||
BUCHART, Marion | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | Scottish | Government Affairs Manager | 280949280001 | ||||
COYLE, Kirstin Rhona | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Scotland | Scotland | British | Project Manager | 252254740002 | ||||
DAVISON, Hilary Williamson | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Health & Wellbeing Consultant | 214733430001 | ||||
DICKSON, Ian | Director | 7 Romney Avenue G44 5AW Glasgow | Scotland | British | Retired | 153780002 | ||||
DRUMMOND, Susan Allison | Director | Kirkcaldy Road G41 4LD Glasgow 12, 80 Scotland | Scotland | British | Operations Manager | 203640180001 | ||||
GILL, Brendan James | Director | 3a Sherbrooke Drive Pollokshields G41 5AA Glasgow Flat 2/2 | British | Accountant (Retired) | 112278900002 | |||||
GREEN, Elaine | Director | Chapel Street Industrial Estate G20 9BQ Glasgow Revive Ms Support Scotland | Scotland | British | Retired | 214823820001 | ||||
HAMILTON, Kimberley Anne | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | British | Pr Manager | 157375790001 | ||||
HODGSON, Irving | Director | Chapel Street Estate Maryhill G20 9BQ Glasgow Unit 16 | Scotland | British | Retired | 134760480001 | ||||
JONES, Derek | Director | Chapel Street Estate Maryhill G20 9BQ Glasgow Unit 16 | Scotland | British | Executive Director | 49108710001 | ||||
KYLE, John Andrew | Director | 50 Lubnaig Road Newlands G43 2RX Glasgow | Scotland | British | Solicitor | 60270240001 | ||||
LAFFERTY, Daniel | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | Scottish | Strategy & Engagement Officer | 281324400001 | ||||
LININGTON, Christopher, Professor | Director | Chapel Street Estate Maryhill G20 9BQ Glasgow Unit 16 | Scotland | British | University Professor | 160718390001 | ||||
MACKAY, Neil Sinclair Davis, Dr | Director | Chapel Street Estate Maryhill G20 9BQ Glasgow Unit 16 | United Kingdom | British | Medical Practitioner | 112278860001 | ||||
MCCORMICK, Patrick Kelly | Director | Capelrig Gardens Newton Mearns G77 6NF Glasgow Flat G1, 1 Scotland | Scotland | British | Accountant | 206611890001 | ||||
MCGEE, Catherine | Director | Dava Street G51 2JA Glasgow 29 Dava Street Scotland | Scotland | Scottish | Speech And Language Therapist | 250139840001 | ||||
MCINALLY, Thomas | Director | Chapel Street Estate Maryhill G20 9BQ Glasgow Unit 16 | United Kingdom | British | Retired Police Inspector | 149885260001 | ||||
MCLAUGHLIN, Lucille | Director | Douglas Gardens Giffnock G46 6NY Glasgow 7 Scotland | Scotland | British | Retired | 193326690001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para REVIVE MS SUPPORT?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
04 ago 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0