HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED

HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC154396
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED?

    • Producción de productos de carne y carne de ave (10130) / Industrias manufactureras
    • Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos (46320) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Thainstone Centre
    Inverurie
    AB51 5XZ Aberdeenshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MORAY MEAT PRODUCTS LIMITED21 nov 199421 nov 1994

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Raymond Davidson como director el 13 feb 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Keith Gordon Mccall como director el 31 ene 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Raymond Davidson como director el 09 oct 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Watson como director el 09 oct 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 21 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 nov 2012

    Estado de capital el 23 nov 2012

    • Capital: GBP 51,000
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Keith Gordon Mccall como director el 15 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alan Charles Craig como director el 10 feb 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Patrick John Machray como director el 10 feb 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 21 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de David Brown como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Thomas Charles Johnston como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Patrick John Machray como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Bruce Mcintosh como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Douglas Fowlie como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Innes Farquharson como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John William Gordon como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Strachan Cruickshank como director el 18 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de William George Mackie como director el 13 sept 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Thomas Charles Johnston como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2010

    9 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LC SECRETARIES LIMITED
    Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House 52-54
    Secretario corporativo
    Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House 52-54
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC299827
    112802860001
    MACHRAY, Patrick John
    Daviot
    AB51 0JA Inverurie
    Bilboa
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Director
    Daviot
    AB51 0JA Inverurie
    Bilboa
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish27189700001
    WATSON, Peter
    Durris
    AB31 6DJ Banchory
    Darnford
    United Kingdom
    Director
    Durris
    AB31 6DJ Banchory
    Darnford
    United Kingdom
    United KingdomBritish175103400001
    DINNES, Garry Walker
    Muirfield Orchard Road
    IV36 0LH Forres
    Morayshire
    Secretario
    Muirfield Orchard Road
    IV36 0LH Forres
    Morayshire
    British19524700003
    GALE, Lesley Fiona
    Newseat Of Culsalmond, Fisherford
    Rothienorman
    AB51 8YQ Inverurie
    Aberdeenshire
    Secretario
    Newseat Of Culsalmond, Fisherford
    Rothienorman
    AB51 8YQ Inverurie
    Aberdeenshire
    British67815370001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secretario designado
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    BROWN, David
    Burnside Of Dipple
    IV32 7QA Fochabers
    Morayshire
    Director
    Burnside Of Dipple
    IV32 7QA Fochabers
    Morayshire
    ScotlandBritish43834530001
    COWE, Dennis Sherriffs
    Aldersyde
    Gladstone Road
    AB54 8BW Huntly
    Aberdeenshire
    Director
    Aldersyde
    Gladstone Road
    AB54 8BW Huntly
    Aberdeenshire
    British1040230002
    CRAIG, Alan Charles
    Saltpans
    Charlestown
    KY11 3EB Dunfermline
    1
    Fife
    Scotland
    Director
    Saltpans
    Charlestown
    KY11 3EB Dunfermline
    1
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish138003220001
    CRUICKSHANK, James Strachan
    Westerton Of Folla
    Meikle Wartle
    AB51 5BQ Inverurie
    Aberdeenshire
    Director
    Westerton Of Folla
    Meikle Wartle
    AB51 5BQ Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish125953480001
    DAVIDSON, Raymond
    Newburgh
    AB41 6AQ Ellon
    Mains Of Foveran
    United Kingdom
    Director
    Newburgh
    AB41 6AQ Ellon
    Mains Of Foveran
    United Kingdom
    United KingdomBritish175103340001
    DINNES, Garry Walker
    Muirfield Orchard Road
    IV36 0LH Forres
    Morayshire
    Director
    Muirfield Orchard Road
    IV36 0LH Forres
    Morayshire
    British19524700003
    DINNES, Roy James
    6 St. Leonards Drive
    IV36 0GD Forres
    Morayshire
    Director
    6 St. Leonards Drive
    IV36 0GD Forres
    Morayshire
    British1227250002
    DON, John Alexander Campbell, Justice Of The Peace (Jp)
    Freefield Farm
    Old Rayne
    AB52 6SY Insch
    Aberdeenshire
    Director
    Freefield Farm
    Old Rayne
    AB52 6SY Insch
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish17992360001
    FARQUHARSON, John Innes
    Darley
    Fyvie
    AB53 8LH Turriff
    Aberdeenshire
    Director
    Darley
    Fyvie
    AB53 8LH Turriff
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish83313350001
    FOWLIE, John Douglas
    Millhill
    Longside
    AB42 5BJ Peterhead
    Aberdeenshire
    Director
    Millhill
    Longside
    AB42 5BJ Peterhead
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish93072520001
    GORDON, John William
    Wellheads
    AB54 4UX Huntly
    Aberdeenshire
    Director
    Wellheads
    AB54 4UX Huntly
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish116035000001
    JOHNSTON, Thomas Charles
    Drumblade
    AB54 6BJ Huntly
    Cottown
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Director
    Drumblade
    AB54 6BJ Huntly
    Cottown
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137193360001
    MABBOTT, Stephen
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Director designado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish900008380001
    MACHRAY, Patrick John
    Daviot
    AB51 0JA Inverurie
    Bilboa
    Aberdeenshire
    Director
    Daviot
    AB51 0JA Inverurie
    Bilboa
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish27189700001
    MACKIE, William George
    Whiteside Farm
    Tullynessle
    AB33 8DE Alford
    Aberdeenshire
    Director
    Whiteside Farm
    Tullynessle
    AB33 8DE Alford
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish83809230001
    MAIR, Kenneth John
    Kinneslea
    Wood Of Muiresk
    AB53 4HD Turriff
    Aberdeenshire
    Director
    Kinneslea
    Wood Of Muiresk
    AB53 4HD Turriff
    Aberdeenshire
    ScotlandScottish62318910002
    MANSON, Colin
    Brodieshill Farm
    IV36 2QU Forres
    Morayshire
    Director
    Brodieshill Farm
    IV36 2QU Forres
    Morayshire
    ScotlandBritish62318350001
    MCCALL, Keith Gordon
    Gosford Road
    EH32 OLF Longniddry
    Bruilin
    United Kingdom
    Director
    Gosford Road
    EH32 OLF Longniddry
    Bruilin
    United Kingdom
    ScotlandBritish168498060001
    MCINTOSH, John Bruce
    Goval Farm
    Dyce
    AB2 0HS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    Goval Farm
    Dyce
    AB2 0HS Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish1040240001
    PACK, Brian Sidney
    Kartonhall
    Daviot
    AB51 0JH Inverurie
    Aberdeenshire
    Director
    Kartonhall
    Daviot
    AB51 0JH Inverurie
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish311100002
    WILLIAMS, Neil Robert
    Ballaterach
    Dinnet
    AB34 5NX Aboyne
    Aberdeenshire
    Director
    Ballaterach
    Dinnet
    AB34 5NX Aboyne
    Aberdeenshire
    British62505040001

    ¿Tiene HIGHLAND COUNTRY FOODS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 18 abr 1995
    Entregado el 05 may 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 may 1995Registro de un cargo (410)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0