SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC155408
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    • (1598) /

    ¿Dónde se encuentra SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Third Floor West Edinburgh Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPEYSIDE GLENLIVIT WATER COMPANY LIMITED21 mar 199521 mar 1995
    M M & S (2247) LIMITED18 ene 199518 ene 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2006

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en CVL

    12 páginasLIQ14(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de * Atholl Exchange 6 Canning Street Edinburgh EH3 8EG* el 13 mar 2013

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * 2Nd Floor, Capital House 2 Festival Square Edinburgh Midlothian EH3 9SU* el 25 ene 2012

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * Invocas 2Nd Floor, Langstane House 221/229 Union Street Aberdeen AB11 6DR* el 15 abr 2011

    2 páginasAD01

    Aviso de cambio de administración a liquidación voluntaria de acreedores

    11 páginas2.25B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    11 páginas2.20B(Scot)

    legacy

    2 páginas2.18B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    8 páginas2.20B(Scot)

    legacy

    19 páginas2.18B(Scot)

    Declaración de la propuesta del administrador

    13 páginas2.16B(Scot)

    Nombramiento de un administrador

    3 páginas2.11B(Scot)

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    4 páginas410(Scot)

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    14 páginasAA

    legacy

    42 páginas363a

    legacy

    3 páginas88(2)R

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    15 páginasAA

    legacy

    6 páginas410(Scot)

    legacy

    3 páginas419a(Scot)

    legacy

    42 páginas363a

    legacy

    3 páginas88(2)R

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Secretario
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    BritishAccountant7130710001
    DRESHER, Leontina Megan
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    Director
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    United KingdomHungarianCompany Director30141330001
    PRICE, Stephen
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector73146560001
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Director
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    EnglandBritishAccountant7130710001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Secretario
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    BritishStud Farmer68375010001
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Secretario
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    BritishFarming70901470001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Secretario
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    BritishChartered Accountant61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Secretario
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    British57563390001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor74298510001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secretario
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    BritishInvestment Banker14578540001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secretario
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    BritishInvestment Banker14578540001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, John Arthur
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    Director
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor34883320001
    BEVAN, Jonathan Stuart Vaughan
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    Director
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    BritishMerchant39232450001
    CHILD, Peter John
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    Director
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    BritishFood Technologist24036010001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Director
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    BritishStud Farmer68375010001
    COURTNEY, John Adam
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director15297560005
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Director
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    United KingdomBritishStud Farmer70901470001
    EVERETT, Grace Mary
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Director
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    BritishConsultant70901230001
    EVERETT, Timothy John
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Director
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritishFarmer70901170001
    FERNBACK, Alan Geoffrey
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    Director
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    EnglandBritishDirector38497170001
    HEINRICH, Gisbert
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    Director
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    BritishProdution Director And Manager44530030001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Director
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    EnglandBritishChartered Accountant61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Director
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishEngineer57563390001
    MARNER, Christian
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Director
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    DanishConsultant52354890003
    MILLAR, Andrew Donaldson
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    Director
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    BritishBusiness Consultant116870001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Director
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    United KingdomBritishBusiness Consultant14578540001
    SULLY, Malcolm Keith
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    Director
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    BritishMarketing And Sales Consultant39278310002
    WOOD - ROBERTS, David
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    Director
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    BritishSalesman64744510006
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    ¿Tiene SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 12 mar 2008
    Entregado el 02 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Floating charge over 1 x 2007 zambelli fully automatic trayloader/shrink wrapping machine, model number LFT20/v single lane version - serial number 4621.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Commercial Asset Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 02 abr 2008Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 02 nov 2006
    Entregado el 22 nov 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    As continuing security for the payment or discharge othe secured liabilities all of the equipment and other chattels. See form 410 for further details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Davenham Trust PLC
    Transacciones
    • 22 nov 2006Registro de un cargo (410)
    Bond & floating charge
    Creado el 29 abr 2004
    Entregado el 14 may 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 may 2004Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 10 sept 1999
    Entregado el 23 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Speyside Glenlivet Limited
    Transacciones
    • 23 sept 1999Registro de un cargo (410)
    • 30 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 mar 2009Inicio de la administración
    04 mar 2010Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Profesional
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Profesional
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    2
    FechaTipo
    04 mar 2010Inicio de la liquidación
    14 nov 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Profesional
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Profesional
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0