SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED

SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSPEYSIDE GLENLIVET LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC155411
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA Midlothian
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    M M & S (2246) LIMITED18 ene 199518 ene 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    134 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 ene 2013

    Estado de capital el 21 ene 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Bernice Margaret Cuthbert el 18 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Datafile (Nominees) Ltd el 18 ene 2010

    2 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    4 páginasAA

    legacy

    7 páginas363a

    legacy

    10 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    4 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005

    4 páginasAA

    legacy

    9 páginas363s

    legacy

    páginas363(288)

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de SPEYSIDE GLENLIVET LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DATAFILE (NOMINEES) LTD
    Manor Courtyard
    Aston Sandford
    HP17 8JB Aylesbury
    The Dairy
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Manor Courtyard
    Aston Sandford
    HP17 8JB Aylesbury
    The Dairy
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3240292
    101155020001
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Director
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish70901470001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Secretario
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Secretario
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    British70901470001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Secretario
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    British61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Secretario
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    British57563390001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secretario
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, John Arthur
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    Director
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    EnglandBritish34883320001
    CHILD, Peter John
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    Director
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    British24036010001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Director
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    EVERETT, Grace Mary
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Director
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    British70901230001
    EVERETT, Timothy John
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Director
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish70901170001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Director
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    EnglandBritish61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Director
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish57563390001
    MARNER, Christian
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Director
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Danish52354890003
    MILLAR, Andrew Donaldson
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    Director
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    British116870001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Director
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    United KingdomBritish14578540001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Director
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    United KingdomBritish14578540001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0