G.N.BEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaG.N.BEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC156624
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de G.N.BEN LIMITED?

    • fabricación de productos farmacéuticos básicos (21100) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra G.N.BEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Est
    ML2 0JG Wishaw
    Lanarkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de G.N.BEN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WRAP FILM HOLDINGS LIMITED28 nov 200728 nov 2007
    WRAP FILM HOLDINGS LIMITED29 abr 199729 abr 1997
    MACROCOM (303) LIMITED15 mar 199515 mar 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de G.N.BEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para G.N.BEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 15 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 abr 2013

    Estado de capital el 05 abr 2013

    • Capital: GBP 58,675
    SH01

    Nombramiento de Mr Giovanni Benedetti como secretario el 20 feb 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Andrew Palmer como secretario el 20 feb 2013

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Andrew Palmer como secretario el 04 oct 2011

    3 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Déclaration annuelle établie au 15 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2008

    8 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    15 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed wrap film holdings LIMITED\certificate issued on 07/12/07
    3 páginasCERTNM

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Acquisition agreement 30/10/07
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de G.N.BEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENEDETTI, Giovanni
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Est
    ML2 0JG Wishaw
    Lanarkshire
    Secretario
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Est
    ML2 0JG Wishaw
    Lanarkshire
    175994960001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Director
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    United KingdomBritishCompany Director90520001
    BACON, Philip David
    Lydebrook Cottage, Littleworth
    Little Wenlock
    TF6 5AX Telford
    Shropshire
    Secretario
    Lydebrook Cottage, Littleworth
    Little Wenlock
    TF6 5AX Telford
    Shropshire
    British53565170001
    BROWN, Adrian Richard
    Kettlemore Lane
    TF11 8RG Sheriffhales
    Fairways
    Shropshire
    Uk
    Secretario
    Kettlemore Lane
    TF11 8RG Sheriffhales
    Fairways
    Shropshire
    Uk
    BritishManaging Director111976650003
    CLARK, Michael David
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    Secretario
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    BritishDirector111876120001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secretario designado
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    PALMER, Andrew
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Secretario
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    British163887910001
    SPRAGG, Mark Richard
    The Rowans 5 Newgate
    Pattingham
    WV6 7AG Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    The Rowans 5 Newgate
    Pattingham
    WV6 7AG Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director68972170002
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Secretario
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    BritishManaging Director53458580003
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Secretario
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    BritishManager53458580003
    MACROBERTS
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secretario corporativo
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    32443220001
    BACON, Philip David
    Lydebrook Cottage, Littleworth
    Little Wenlock
    TF6 5AX Telford
    Shropshire
    Director
    Lydebrook Cottage, Littleworth
    Little Wenlock
    TF6 5AX Telford
    Shropshire
    BritishCompany Director53565170001
    BROWN, Adrian Richard
    Kettlemore Lane
    TF11 8RG Sheriffhales
    Fairways
    Shropshire
    Uk
    Director
    Kettlemore Lane
    TF11 8RG Sheriffhales
    Fairways
    Shropshire
    Uk
    United KingdomBritishManaging Director111976650003
    CLARK, Michael David
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    Director
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    BritishDirector111876120001
    CRAIG, Thomas Kirk
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Director
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    United KingdomBritishMan Consultant5050002
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Director designado
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    FERGUSON, Ronald Alistair
    7 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Director
    7 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    BritishCompany Director40114810001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Director designado
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    KOLBE, Richard Bartholomew Allen
    Home Farm Cottage
    Peatswood
    TF9 2PA Market Drayton
    Shropshire
    Director
    Home Farm Cottage
    Peatswood
    TF9 2PA Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director25362720002
    MACKAY, Rupert William Arthur
    Rosewood
    Legh Gardens, Chelford Road
    WA16 8PU Knutsford
    Cheshire
    Director
    Rosewood
    Legh Gardens, Chelford Road
    WA16 8PU Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director102729490001
    MCCORMICK, John Robert
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    Director
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director82210090001
    SPRAGG, Mark Richard
    The Rowans 5 Newgate
    Pattingham
    WV6 7AG Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    The Rowans 5 Newgate
    Pattingham
    WV6 7AG Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director68972170002
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Director
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    United KingdomBritishChartered Accountant53458580003

    ¿Tiene G.N.BEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 06 oct 1999
    Entregado el 19 oct 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 19 oct 1999Registro de un cargo (410)
    • 22 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 15 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 14 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 06 oct 1999
    Entregado el 19 oct 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Giovannie Benedetti
    Transacciones
    • 19 oct 1999Registro de un cargo (410)
    • 19 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 15 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 06 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 06 abr 1995
    Entregado el 11 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 abr 1995Registro de un cargo (410)
    • 25 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 20 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0