CRITIQOM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CRITIQOM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC160484 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CRITIQOM LIMITED?
- fabricación de artículos de papelería (17230) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra CRITIQOM LIMITED?
| Dirección de la sede social | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CRITIQOM LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DOCUMENT OUTSOURCING LIMITED | 29 sept 2005 | 29 sept 2005 |
| STORTEXT UK LIMITED | 11 feb 2000 | 11 feb 2000 |
| STORTEXT LOGISTICS LIMITED | 03 oct 1995 | 03 oct 1995 |
| DUNWILCO (470) LIMITED | 20 sept 1995 | 20 sept 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CRITIQOM LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CRITIQOM LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CRITIQOM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Chris Walsh el 05 ene 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony John Strong como director el 19 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 28 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Gerrard Martin Crawley como director el 30 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Alteraciones a la garantía flotante SC1604840009 | 18 páginas | 466(Scot) | ||
Alteraciones a la garantía flotante SC1604840010 | 16 páginas | 466(Scot) | ||
Registro de la carga SC1604840010, creada el 29 may 2025 | 20 páginas | MR01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2025 au 31 dic 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew David Herd como director el 20 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Christian Alexander Paul Dickson como director el 20 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Pawen Jernas como director el 20 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Marcin Jernas como director el 20 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Mitul Jay Rughani como secretario el 20 mar 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Chris Walsh como director el 23 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Shane William Joseph Woods como director el 23 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Nicholas Keegan como director el 23 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Pawen Jernas como director el 23 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Marcin Jernas como director el 23 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Christopher Johnson como director el 23 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Samantha Jayne Ghysen como secretario el 23 dic 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Registro de la carga SC1604840009, creada el 23 dic 2024 | 16 páginas | MR01 | ||
Cancelación total de la carga SC1604840008 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC1604840007 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 28 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CRITIQOM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUGHANI, Mitul Jay | Secretario | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | 334018820001 | |||||||
| DICKSON, Christian Alexander Paul | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | England | British | 208390720001 | |||||
| HERD, Andrew David | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | England | British | 129949980001 | |||||
| KEEGAN, Nicholas | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Ireland | Irish | 332066450001 | |||||
| SAVAGE, Hayden John | Director | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | 255239970001 | |||||
| WALSH, Christopher James, Mr. | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Ireland | Irish | 332067440002 | |||||
| WOODS, Shane William Joseph | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Ireland | Irish | 332066670001 | |||||
| FRASER, William | Secretario | Woodside Houston PA6 7DD Johnstone 19 Renfrewshire Scotland | British | 140871510001 | ||||||
| GHYSEN, Samantha Jayne | Secretario | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road LE3 1UQ Leicester 133-137 Scudamore Road England | 266282840001 | |||||||
| HARTLEY, Ian | Secretario | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | 172860730001 | |||||||
| KELLY, Paul Matthew | Secretario | 13 Ladysneuk Road FK9 5NE Stirling Stirlingshire | British | 71750740001 | ||||||
| KELLY, Paul Matthew | Secretario | 13 Ladysneuk Road FK9 5NE Stirling Stirlingshire | British | 71750740001 | ||||||
| LAMONT, Julian Callum | Secretario | 51 Queen Margaret Close EH10 7EE Edinburgh | British | 56618420001 | ||||||
| MCCALLUM, Lynne Margaret | Secretario | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | 181896050001 | |||||||
| MCILQUHAM, Lorraine | Secretario | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | 161346900001 | |||||||
| MCNULTY, Gary Edward | Secretario | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | 164409380001 | |||||||
| SAUNDERS, Scott | Secretario | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | British | 72070340003 | ||||||
| WALLACE, Graham Alexander Drummond | Secretario | Brewlands Lodge 22 Newmills Road EH22 2AH Dalkeith Midlothian | British | 70304160001 | ||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| QUILL SERVE LIMITED | Secretario corporativo | 249 West George Street G2 4RB Glasgow Lanarkshire | 110089630001 | |||||||
| BELL, Edward | Director | 20 Newton Court SL4 2SN Old Windsor | British | 95487590001 | ||||||
| COUTTS, Maureen Sheila | Director designado | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | British | 900004630001 | ||||||
| CRAWLEY, Gerrard Martin | Director | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 194792350001 | |||||
| DE HAAN, Peter Charles | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Switzerland | British | 289241980001 | |||||
| EVANS, Adrian Michael | Director | 44 Beckwith Road Dulwich SE24 9LG London | United Kingdom | British | 15391950001 | |||||
| FARMER, Richard | Director | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | 250540630001 | |||||
| FRASER, William | Director | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 82128590002 | |||||
| HARDIE, David | Director designado | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | British | 900004620001 | ||||||
| HARTLEY, Ian | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Scotland | British | 36694500004 | |||||
| HENDERSON, Howard Geoffrey | Director | 28 Adrian Close CF36 3LX Porthcawl Mid Glamorgan | United Kingdom | British | 80242420001 | |||||
| JERNAS, Marcin | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Poland | Polish | 332066220001 | |||||
| JERNAS, Pawen | Director | Document House Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Park Bellshill | Ireland | Polish | 332066270001 | |||||
| JOHNSON, Simon Christopher | Director | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | 110558260001 | |||||
| JOHNSTON, Alan Robert | Director | 37 Grange View EH49 7HY Linlithgow West Lothian | British | 79093650001 | ||||||
| KEELER, Simon Nicholas | Director | 32 Dickens Drive Old Stratford MK19 6NN Milton Keynes | England | British | 79093730001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CRITIQOM LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Outsourcing Group Limited | 06 abr 2016 | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0