MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC160930 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 201 West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow Lanarkshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MILLER/CTP (PACIFIC QUAY) LIMITED | 09 oct 1995 | 09 oct 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Thomas Milloy como director el 25 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Sutherland el 16 oct 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW Scotland a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow Lanarkshire G2 2LW el 05 feb 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW el 04 feb 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Miller Developments Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 feb 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Paul Whiteside como director el 19 ago 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL el 25 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Euan James Edward Haggerty como director el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 ene 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINGWORTH, Guy | Director | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | England | British | 146508050001 | |||||
| MILLOY, David Thomas | Director | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Director | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Canada | British | 66368290041 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Secretario | Woodburn Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 41273760001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Secretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BORLAND, Donald William | Director | 408 Ferry Road EH5 2AD Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| DEANS, Thomas Malcolm | Director | 69 Hillview Road EH12 8QH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 848410001 | |||||
| DEANS, Thomas Malcolm | Director | 69 Hillview Road EH12 8QH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 848410001 | |||||
| GRANT, Pamela | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 114541590001 | |||||
| HAGGERTY, Euan James Edward | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Director | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| MCCORMACK, Robert Keith | Director | 1 Long Meadow Eccleston WA10 4LS St Helens Merseyside | British | 11955530001 | ||||||
| MILLER, Philip Hartley | Director | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| MILLOY, David Thomas | Director | 1 Thorn Avenue Thorntonhall G74 5AT Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| ROBINSON, David | Director | 118 Meadowspot EH10 5UY Edinburgh Lothian | Scotland | United Kingdom | 50541770001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Director | 87 Whitehouse Road EH4 6PB Edinburgh Lothian | United Kingdom | British | 66368290001 | |||||
| TOPHAM, David James | Director | 2 Highgate St Margarets Road WA14 2AP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 78716950001 | |||||
| WHITESIDE, John Paul | Director | Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 | England | British | 16769540002 | |||||
| WOOD, Marlene | Director | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller Developments Holdings Limited | 06 abr 2016 | St. Paul's Churchyard EC4M 8AL London Condor House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Northpoint Developments (No 1) Ltd | 06 abr 2016 | 2-10 Queen Street M2 5JB Manchester St John's House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MILLER NORTHPOINT (PACIFIC QUAY) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 13 ene 1998 Entregado el 21 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 4.78 hectares north of govan road,glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 ago 1997 Entregado el 26 ago 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The obligations undertaken by the company in terms of the shareholders agreement | |
Breve descripción 4.78 hectares to the north of govan road,glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0