WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC161430 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 24/25 St Andrew Square Edinburgh EH2 1AF |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROBOSCOT (19) LIMITED | 07 nov 1995 | 07 nov 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des détails de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 abr 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cessation de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Notification de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Notification de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Nombramiento de Mark Brandwood como director el 30 nov 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Howard David Lincoln como director el 30 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jocelyn Nadauld Brushfield como director el 18 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Barbara Ida Mary Turnbull como director el 23 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Howard David Lincoln como director el 23 oct 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| BRANDWOOD, Mark | Director | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | England | British | 240720570001 | |||||||||
| ROWNEY, James Mccubbin | Director | Princes Street EH2 4EQ Edinburgh 142-144 Midlothian Scotland | Scotland | British | 59551350002 | |||||||||
| CRAIG, Mark | Secretario | 2f2, 7 Polwarth Crescent EH11 1HP Edinburgh | British | 63130650003 | ||||||||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Secretario | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 33 Badger Walk EH52 5TW Broxburn West Lothian | British | 40027890002 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||||||
| MILLS, Alan Ewing | Secretario | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||||||
| SMITH, Carolyn | Secretario | 9 Bedford Court Mowbray Road Upper Norwood SE19 2RW London | British | 68031820001 | ||||||||||
| BEATTIE, Ian David | Director | 21 Calder Avenue KA10 7JT Troon Ayrshire | British | 79483650001 | ||||||||||
| BEATTIE, Robert Henry | Director | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 27224590001 | |||||||||
| BRUSHFIELD, Jocelyn Nadauld | Director | Bishopsgate EC2M 4RB London 280 | England | British | 160922120001 | |||||||||
| CAMPBELL, Hew | Director | 44 Castleknowe Gardens Kirkton Park ML8 5UX Carluke Scotland | British | 1416100007 | ||||||||||
| CARRARO, Philip Andrew | Director | 70 Onslow Gardens SW7 3QD London | United States Citizen | 64702980001 | ||||||||||
| CARTLEDGE, David Edmund | Director | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | 38897330001 | ||||||||||
| CHRISPIN, Simon Jonathan | Director | 41 Claygate Avenue AL5 2HE Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 62029940002 | |||||||||
| CULLINAN, Rory Malcolm | Director | 25 Oakwood Court Abbotsbury Road W14 8JU London | England | British | 149327390001 | |||||||||
| LAMBERT, Mark Andrew | Director | 1 Oakview Cottages Upper Green Road Shipbourne TN11 9PQ Tonbridge Kent | British | 75051270001 | ||||||||||
| LINCOLN, Howard David | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 202721190001 | |||||||||
| MCDONALD, Alastair John | Director | 4 West Mains Road EH9 3BQ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 126186820001 | |||||||||
| MCKEAN, Alan Wallace | Director | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | 1019950002 | ||||||||||
| SACH, Derek Stephen | Director | Hattingley House Hattingley Road, Medstead GU34 5NQ Alton Hampshire | United Kingdom | British | 646390004 | |||||||||
| SACH, Derek Stephen | Director | Warren Lodge 32 Leigh Hill Road KT11 2HZ Cobham Surrey | British | 646390001 | ||||||||||
| SANDERS, Stuart Currie | Director | 25 Greenbank Loan EH10 5SJ Edinburgh | Scotland | British | 77340230001 | |||||||||
| SHEAVILLS, Ernest Michael | Director | Coombe House, 8 Westgarth Avenue Colinton EH13 0BD Edinburgh | British | 34817880001 | ||||||||||
| SPEIRS, Robert | Director | 17 Kings Crescent G84 7RB Helensburgh Dunbartonshire | British | 2592770003 | ||||||||||
| STEWART, Anne Rutherford | Director | 48 Gordon Road EH12 6LU Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 74451550001 | |||||||||
| TOUGH, Eric George William | Director | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | 54132470001 | ||||||||||
| TURNBULL, Barbara Ida Mary | Director | 46 Woodfield Park Colinton EH13 0RB Edinburgh Scotland | Scotland | British | 55903310001 | |||||||||
| WHITEHEAD, Grahame Taylor | Director | Southlea 20 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | 1363570003 | ||||||||||
| WORKMAN, John Donald Black | Director | Flat 1/F 8 Moray Place EH3 6DS Edinburgh | Scotland | British | 78893620002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Natwest Markets Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| N.C. Head Office Nominees Limited | 06 abr 2016 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 03 sept 2009 Entregado el 10 sept 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Land on north east side of main road, brereton, rugeley, staffordshire SF346043. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene WEST REGISTER (PROJECT DEVELOPMENTS) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0