M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | SC161934 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| M-I DRILLING FLUIDS U.K. LIMITED | 11 ene 1996 | 11 ene 1996 |
| WJB (387) LIMITED | 30 nov 1995 | 30 nov 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden judicial Scheme of amalgamation | 8 páginas | OC | ||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Orden judicial Diss by c/order | 8 páginas | OC | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 dic 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aprobación de re-registro | 1 páginas | FOA-RR | ||||||||||||||
Certificado de re-registro de Limitado a Ilimitado | 1 páginas | CERT3 | ||||||||||||||
Re-registro del Memorándum y Estatutos | 28 páginas | MAR | ||||||||||||||
Re-registro de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad privada de responsabilidad ilimitada | 2 páginas | RR05 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr. Kenneth Robert Rait el 12 jun 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jorge Covarrubias-Rico como director el 07 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr. Kenneth Robert Rait como director el 07 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Edward Anselm Fox el 30 jun 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mikki Victoria Corcoran como director el 04 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Edward Anselm Fox como director el 04 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 28 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como secretario el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX, Robert Edward Anselm | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 292365550002 | |||||
| RAIT, Kenneth Robert, Mr. | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 307772460002 | |||||
| DROY MOORE, Pauline | Secretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 158496370002 | |||||||
| GORMLEY, Donald | Secretario | 139 Blenheim Place AB25 2DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 105532790001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Secretario | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 273439800001 | |||||||
| KENNEDY, Robert Lewis | Secretario | Allan Street AB10 6HE Aberdeen 24 | British | 140492750001 | ||||||
| PIA, Paul Dominic | Secretario | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | British | 8812960003 | ||||||
| SMOKER, Simon | Secretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203976090001 | |||||||
| BURNESS SOLICITORS | Secretario designado corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| ANDREWS, Jim | Director | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 163190540001 | |||||
| BARKER, Larry Douglas | Director | 4860 James Lane Fulshear 77441 Texas Usa | American | 36726300002 | ||||||
| BOYAULT, Gwenola Jacqueline Stephanie | Director | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | French | 216352570001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Director | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| CHANDLER, Richard Edwin | Director | 24611 Mount Auburn Katy Texas Usa | American | 40271390001 | ||||||
| CHEETHAM, Neil James | Director | Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Peregrine House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 260005340001 | |||||
| CORCORAN, Mikki Victoria | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 261075650001 | |||||
| COVARRUBIAS-RICO, Jorge | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | Mexican | 263969070002 | |||||
| GAMBLE, Ernest Richard Herman | Director | Milestones Wells Road Westbury Sub Mendip BA5 1EX Wells Somerset | British | 29782250001 | ||||||
| GIBB, William Ian Alexander | Director | St Eunans Road AB34 5HH Aboyne Kinnaird Aberdeenshire | United Kingdom | British | 103544230002 | |||||
| GORMLEY, Donald | Director | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 105532790001 | |||||
| GUEDEZ, Manuel Alejandro | Director | Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Peregrine House Scotland Scotland | Scotland | Italian | 225316000001 | |||||
| HOEING-COSENTINO, Karin Annette | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | German | 183326450001 | |||||
| JACK, Ian | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | British | 103412640012 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| MACDONALD, Steven Henry | Director | 35 Forest Avenue AB15 4TU Aberdeen Scotland | British | 60534330001 | ||||||
| MACKENZIE, Donald | Director | 2345 Bering Drive 446 Houston Texas 77057 Usa | Canadian | 40271380001 | ||||||
| MCBEATH, Brian Laurence | Director | Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Peregrine House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 218155990001 | |||||
| MINTON, Reginald Carey, Dr | Director | Hillview Crescent Cults AB15 9RT Aberdeen 40 Aberdeenshire | British | 132346030001 | ||||||
| MONTGOMERY, Brian Sinclair | Director | 12 Sunnyside Gardens AB24 3LZ Aberdeen | British | 88195820001 | ||||||
| PARK, Alexander | Director | Brackenburn Drumoak AB31 5AT Banchory Aberdeenshire | British | 49570380001 | ||||||
| POPPLESTONE, Andrew | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | United Kingdom | British | 70206340004 | |||||
| RETZ, Rolf Helland | Director | Ragkroken 1 N4042 Stavanger Norway | Norwegian | 55259990001 | ||||||
| RIVERS, Christopher Iain Samuel | Director | 3410 Candleway Spring 77388 Texas U.S.A. | British | 39176400001 | ||||||
| SAMWAYS, Roger Sinclair | Director | Moredun Lodge Culter House Road AB13 0NQ Milltimber Aberdeen | British | 77853610001 | ||||||
| SCOTT, John | Director | Smiddy Park Kinneff DD10 0UD Montrose 5 Angus | British | 116648310002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de M-I DRILLING FLUIDS U.K. UNLIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlumberger Oilfield Uk Plc | 29 nov 2017 | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Schlumberger Oilfield Uk Plc | 06 abr 2016 | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0