AZK99 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAZK99 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC162889
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AZK99 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra AZK99 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    26 Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AZK99 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MURRAY METALS GROUP LIMITED10 may 200110 may 2001
    MURRAY METAL HOLDINGS LIMITED18 sept 199718 sept 1997
    MURRAY MSL LIMITED27 sept 199627 sept 1996
    MIMTEC SERVICES (1996) LIMITED19 ene 199619 ene 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AZK99 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para AZK99 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AZK99 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed murray metals group LIMITED\certificate issued on 24/06/15
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name24 jun 2015

    Aviso de cambio de nombre

    CONNOT

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2014 au 31 dic 2014

    3 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 feb 2015

    Estado de capital el 27 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de 10 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DR a 26 Charlotte Square Edinburgh EH2 4ET el 27 feb 2015

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de David William Murray Horne como secretario el 17 nov 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Michael Scott Mcgill como director el 17 nov 2014

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 28 ago 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ene 2014

    Estado de capital el 14 ene 2014

    • Capital: GBP 8,057,935
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Sir David Edward Murray el 17 may 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    16 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 07 mar 2012

    • Capital: GBP 8,057,935
    4 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de AZK99 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MURRAY, David Edward
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    Director
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    ScotlandBritish34535230003
    HEGARTY, Eamon James
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Secretario
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    British36657620002
    HORNE, David William Murray
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Secretario
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    British41593900004
    HORNE, David William Murray
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    British41593900002
    TAHIR, Sarah
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    Secretario
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    British38346270001
    COCKBURN, Kenneth Andrew
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    Director
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    ScotlandBritish835820002
    COCKBURN, Kenneth Andrew
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    Director
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    ScotlandBritish835820002
    HEGARTY, Eamon James
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Director
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    ScotlandBritish36657620002
    HILL, Graeme Everitt
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Director
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    EnglandBritish144984260001
    HORNE, David William Murray
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Director
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    British41593900002
    MACDONALD, James
    175 Whitehouse Road
    Barnton
    EH4 6DD Edinburgh
    Director
    175 Whitehouse Road
    Barnton
    EH4 6DD Edinburgh
    ScotlandBritish159510002
    MCGILL, Michael Scott
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Director
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish99070570001
    MCKIE, Robert Gordon
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30277090001
    WILSON, James Donald Gilmour
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Director
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish69298770001

    ¿Tiene AZK99 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Shares pledge
    Creado el 29 jun 2010
    Entregado el 09 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledgors entire right, title and interest in and to the shares.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 jul 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Shares pledge
    Creado el 21 abr 2010
    Entregado el 06 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledgor's entire, right, title and interest in and to the shares.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 may 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignation in security of accounts
    Creado el 20 abr 2010
    Entregado el 06 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Entire, right, title and interest in and to the accounts and the deposits.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 may 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 20 abr 2010
    Entregado el 04 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 may 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 feb 1996
    Entregado el 04 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 mar 1996Registro de un cargo (410)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0