DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED

DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC163521
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED?

    • Actividades de consultoría de gestión que no sean gestión financiera (70229) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MACKENZIE PARTNERSHIP SERVICES LIMITED29 feb 199629 feb 1996
    BLP 961 LIMITED20 feb 199620 feb 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    9 páginasLIQ13(Scot)

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 16 dic 2015

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de 10 George Street Edinburgh EH2 2DZ a 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA el 12 dic 2017

    2 páginasAD01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 7th Floor, Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 7th Floor, Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 7th Floor, Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS a 10 George Street Edinburgh EH2 2DZ el 30 dic 2015

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 16 dic 2015

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Ian James Adamson como director el 19 nov 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Karen Jane Booth como director el 19 nov 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 sept 2015

    Estado de capital el 09 sept 2015

    • Capital: GBP 251,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Karen Jane Booth como director el 01 abr 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen James Morriss como director el 01 abr 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 sept 2014

    Estado de capital el 05 sept 2014

    • Capital: GBP 251,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2013

    12 páginasAA

    Nombramiento de Mr Ian James Adamson como secretario

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Patrick Paul Flaherty como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Waltho como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Steven Waltho como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 sept 2013

    Estado de capital el 11 sept 2013

    • Capital: GBP 251,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mr Stephen James Morriss como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rebecca Seeley como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ADAMSON, Ian James
    63 - 77 Victoria Street
    AL1 3ER St. Albans
    Aecom House
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    63 - 77 Victoria Street
    AL1 3ER St. Albans
    Aecom House
    Hertfordshire
    England
    187091640001
    ADAMSON, Ian James
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    EnglandBritish156073390001
    FLAHERTY, Patrick Paul
    High Holborn
    WC1V 6QS London
    Midcity Place
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6QS London
    Midcity Place
    England
    United KingdomBritish64396600002
    BARNES, Ian Sinclair
    39 Smiths Way
    Water Orton
    B46 1TW Birmingham
    Secretario
    39 Smiths Way
    Water Orton
    B46 1TW Birmingham
    British73874360001
    BELL, Douglas Albert
    18 Dickies Wells
    FK12 5JB Alva
    Clackmannanshire
    Secretario
    18 Dickies Wells
    FK12 5JB Alva
    Clackmannanshire
    British45134700001
    BROWNE, Henry Swanson
    9 Abernethy Place
    Newton Mearns
    G77 5UD Glasgow
    Secretario
    9 Abernethy Place
    Newton Mearns
    G77 5UD Glasgow
    British46828450002
    HORNER, Jeremy David Nelson
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    Secretario
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    163949890001
    JAMES, Muir
    2 Threestanes Road
    ML10 6DX Strathaven
    Allan Villa
    Lanarkshire
    Secretario
    2 Threestanes Road
    ML10 6DX Strathaven
    Allan Villa
    Lanarkshire
    British136734140001
    MUIR, James
    1 Crawford Street
    ML10 6AE Strathaven
    Lanarkshire
    Secretario
    1 Crawford Street
    ML10 6AE Strathaven
    Lanarkshire
    British100304890001
    WALTHO, Steven
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    Secretario
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    170191350002
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Secretario designado corporativo
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005150001
    ABERCROMBIE, Campbell Peter
    14 Glen Lochay Gardens
    Cumbernauld
    G68 0DY Glasgow
    Director
    14 Glen Lochay Gardens
    Cumbernauld
    G68 0DY Glasgow
    British84529250001
    BELL, Douglas Albert
    18 Dickies Wells
    FK12 5JB Alva
    Clackmannanshire
    Director
    18 Dickies Wells
    FK12 5JB Alva
    Clackmannanshire
    British45134700001
    BOOTH, Karen Jane
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    Director
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United KingdomBritish192636860001
    BROWNE, Henry Swanson
    9 Abernethy Place
    Newton Mearns
    G77 5UD Glasgow
    Director
    9 Abernethy Place
    Newton Mearns
    G77 5UD Glasgow
    ScotlandBritish46828450002
    DUNLOP, Walter John
    3 Birkfield Loan
    ML8 4PY Carluke
    Director
    3 Birkfield Loan
    ML8 4PY Carluke
    ScotlandBritish84529440001
    FRAME, Russell
    31 Limekilns
    Pencaitland
    EH34 5HF East Lothian
    Director
    31 Limekilns
    Pencaitland
    EH34 5HF East Lothian
    British84529560001
    HORNER, Jeremy David Neilson
    100 Vineyard Hill Road
    Wimbledon
    SW19 7JJ London
    Director
    100 Vineyard Hill Road
    Wimbledon
    SW19 7JJ London
    UkBritish42208960001
    LOUDON, William
    34 Montgomerie Terrace
    PA17 5DT Skelmorlie
    Ayrshire
    Director
    34 Montgomerie Terrace
    PA17 5DT Skelmorlie
    Ayrshire
    ScotlandBritish148793650001
    MACKENZIE, Samuel Macdonald
    31 Cleveden Road
    G10 3DJ Glasgow
    Director
    31 Cleveden Road
    G10 3DJ Glasgow
    ScotlandScottish141471570001
    MCKENNA, Gerald
    33 Glen Sannox Drive
    Crofters View Craigmarloch
    G68 0DP Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    33 Glen Sannox Drive
    Crofters View Craigmarloch
    G68 0DP Cumbernauld
    Lanarkshire
    British115276860001
    MCKINNON, Donald Archibald
    39 Carlaverock Road
    Newlands
    G43 2RZ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    39 Carlaverock Road
    Newlands
    G43 2RZ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish45134680004
    MCQUARRIE, Craig
    39 Evan Drive
    G46 6NQ Giffnock
    Lanarkshire
    Director
    39 Evan Drive
    G46 6NQ Giffnock
    Lanarkshire
    British118653740001
    MILNE, Gordon Bruce
    129 Duthie Terrace
    AB10 7PT Aberdeen
    Director
    129 Duthie Terrace
    AB10 7PT Aberdeen
    United KingdomBritish33799160002
    MORRISS, Stephen James
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    Director
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    EnglandBritish158576960001
    MUIR, James
    1 Crawford Street
    ML10 6AE Strathaven
    Lanarkshire
    Director
    1 Crawford Street
    ML10 6AE Strathaven
    Lanarkshire
    United KingdomBritish100304890001
    OUTRAM, Andrew Barry David
    10 Mcewan Way
    Torrance
    G64 4EF Glasgow
    Director
    10 Mcewan Way
    Torrance
    G64 4EF Glasgow
    ScotlandBritish141735420001
    REID, Donald
    32 Nungate Gardens
    Haddington
    EH41 4EE East Lothian
    Director
    32 Nungate Gardens
    Haddington
    EH41 4EE East Lothian
    British142251780001
    ROBERTSON, Douglas John
    48 Smithycroft
    ML3 7UL Hamilton
    Director
    48 Smithycroft
    ML3 7UL Hamilton
    ScotlandBritish81330470001
    SEELEY, Rebecca Jayne
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    Director
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    United KingdomBritish164297650002
    STIRLING, Gordon Archibald
    8 Viewfield Avenue
    Milton Of Campsie
    G66 8HB Glasgow
    Director
    8 Viewfield Avenue
    Milton Of Campsie
    G66 8HB Glasgow
    British45134670002
    SWEENEY, Paul Joseph
    11 Doonview Gardens
    Doonfoot
    KA7 4HZ Ayr
    Director
    11 Doonview Gardens
    Doonfoot
    KA7 4HZ Ayr
    British84529110001
    TENNANT, Craig
    49 Douglas Muir Drive
    Milngavie
    G62 7RJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    49 Douglas Muir Drive
    Milngavie
    G62 7RJ Glasgow
    Lanarkshire
    British84529180002
    WALTHO, Steven William
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    Director
    Floor, Aurora 120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    7th
    United Kingdom
    United KingdomBritish202761000001
    BLP CREATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Director designado corporativo
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005130001

    ¿Tiene DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 09 abr 2009
    Entregado el 23 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 abr 2009Registro de un cargo (410)
    • 14 sept 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 08 abr 2002
    Entregado el 16 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 abr 2002Registro de un cargo (410)
    • 29 sept 2010Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)

    ¿Tiene DAVIS LANGDON MACKENZIE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    16 dic 2015Inicio de la liquidación
    25 jun 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0