NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN
Visión general
| Nombre de la empresa | NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | SC163598 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Dirección de la sede social | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EPILEPSY WEST LOTHIAN | 08 nov 2001 | 08 nov 2001 |
| THE WEST LOTHIAN EPILEPSY RESOURCE CENTRE | 21 feb 1996 | 21 feb 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 05 abr 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 05 ene 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 23 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 24 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Clare Marie Dooley como director el 21 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Colin Robertson como secretario el 10 feb 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Gillian Anne Harmer como director el 21 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Colin Stuart Robertson como director el 21 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 26 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Nicola Henderson como director el 19 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Stuart como director el 20 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Notification de Kevin Fullerton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 feb 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Jane Stuart en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 feb 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de Tracey-Anne Morrison como director el 14 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Sarena Chrystal Norwood como director el 31 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Tracey-Anne Morrison como director el 08 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Swarena Chrystal Norwood el 10 nov 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mrs Swarena Chrystal Norwood como director el 08 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Notification de Jane Stuart en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 nov 2022 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Mike Kirkbride en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 nov 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de Mike Kirkbride como director el 08 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 19 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Linda Joy Peddie como director el 14 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOLEY, Clare Marie | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 107534010001 | |||||
| FULLERTON, Kevin | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 260285120001 | |||||
| HENDERSON, Nicola | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 321080740001 | |||||
| LEWIS, Gillian Margaret | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | Scottish | 287283770001 | |||||
| PEDDIE, Linda Joy | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 300173010001 | |||||
| BUCHANAN, Ian | Secretario | 54 Pentland Park Craigshill EH54 5NS Livingston West Lothian | British | 47746920001 | ||||||
| HILL, John | Secretario | 6 Maukeshill Court Livingston Village EH54 7AX Livingston West Lothian | British | 59698000001 | ||||||
| ROBERTSON, Colin | Secretario | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | British | 149418880001 | ||||||
| SPENCE, Jennifer | Secretario | 45 Kirkfield West Livingston Village EH54 7BE Livingston West Lothian | British | 46378410001 | ||||||
| STEVENSON, Audrey | Secretario | 40 Traprain Crescent EH48 2BD Bathgate West Lothian | Scottish | 110802550001 | ||||||
| TAYLOR, Debi | Secretario | 1 Bickerton Croft Hens Nest Road EH47 8EX Whitburn West Lothian | British | 103258010001 | ||||||
| WATT, Janet Douglas | Secretario | 66 Granby Avenue EH54 6LD Livingston West Lothian | British | 89618340001 | ||||||
| AITKEN BATTY, Jane | Director | 10 Bowling Green Road Kirkliston Midlothian | British | 46378400002 | ||||||
| ALLAN, Lorraine Elizabeth | Director | 10 Kirkgate EH55 8AE West Calder West Lothian | British | 101497480001 | ||||||
| ANDERSON, George | Director | 133 Ambrose Rise Dedridge EH54 6JX Livingston West Lothian | British | 47746610001 | ||||||
| ARMSTRONG, Geoff | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 218963840001 | |||||
| BEATTIE, Moira Barnes Owens | Director | Holmknowe 1 Murieston Way EH54 9AR Livingston West Lothian | British | 60043130001 | ||||||
| CADDIE, James Murdoch | Director | 35 Baldric Road Knightswood G13 3QJ Glasgow | British | 47746500001 | ||||||
| GORMLEY, Jean Catherine | Director | 5 Eastfield Road Fauldhouse EH47 9LE Bathgate West Lothian | Scotland | British | 71080290001 | |||||
| GRENNAN, Patricia Bernadette, Staff Nurse | Director | 53 Manitoba Avenue Howden EH54 6LL Livingston West Lothian | British | 101497420001 | ||||||
| HANDS, Elizabeth | Director | 31 Etna Court Armadale EH48 2TD Bathgate West Lothian | British | 123877140001 | ||||||
| HARMER, Gillian Anne | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 271213590001 | |||||
| HENDERSON, Janet | Director | 30 Eastwood Park Fauldhouse EH47 9HL West Lothian | Scotland | British | 161822360001 | |||||
| IBBOTSON, Mary Christine | Director | 4 Columbia Avenue EH54 6PR Livingston West Lothian | British | 59697930001 | ||||||
| INGROUILLE, Michael Carre | Director | 14 Middlewood Park EH54 8AZ Livingston West Lothian | British | 49006430001 | ||||||
| JOHNSTON, Caroline | Director | 19 Beresford Rise Dedridge EH54 6DE Livingston West Lothian | British | 56137880001 | ||||||
| KIRKBRIDE, Mike | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland | British | 213639620001 | |||||
| LOGUE, Daniel, Councillor | Director | 55 Murieston Valley EH54 9HJ Livingston West Lothian | British | 80133670001 | ||||||
| MALCOLM, Edward Anderson | Director | Sligachan 40 Bankton Park West EH54 9BP Livingston West Lothian | Scotland | British | 34472760001 | |||||
| MARSHALL, Mary Ann | Director | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Scotland Britain | British | 173952190002 | |||||
| MCCAFFREY, Joanna | Director | 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Bloom House West Lothian Scotland | Scotland | British | 213630400001 | |||||
| MCCORT, Peter Thomas | Director | 18 Netherton Place Whitburn EH47 8JG Bathgate West Lothian | British | 68530320001 | ||||||
| MCGINLEY, James | Director | 2 Market Lane EH49 7AJ Linlithgow West Lothian | Scottish | 757380001 | ||||||
| MCGROUTHER, David Lindsay Campbell | Director | 138 Easter Bankton EH54 9BH Livingston West Lothian | Scotland | Scottish | 47942760001 | |||||
| MCISAAC, Elizabeth Myra | Director | 217 Raeburn Rigg EH54 8PL Livingston West Lothian | British | 113368010001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NEW DIRECTIONS WEST LOTHIAN?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Kevin Fullerton | 20 feb 2024 | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | No | ||||
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Dr Jane Stuart | 08 nov 2022 | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Sí | ||||
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Mr Mike Kirkbride | 02 feb 2022 | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Sí | ||||
Nacionalidad: Scottish País de residencia: Scotland | |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Mike Kirkbride | 10 feb 2021 | Main Street Livingston Village EH54 7AF Livingston Bloom House Scotland | Sí | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Mrs Audrey Stevenson | 01 ene 2017 | Bloom House 10 Main Street EH54 7AF Livingston Village Livingston, | Sí | ||||
Nacionalidad: Scottish País de residencia: Scotland | |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0