RBS MEZZANINE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RBS MEZZANINE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC164882 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RBS MEZZANINE LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra RBS MEZZANINE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 7 Castle Street EH2 3AH Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RBS MEZZANINE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROBOSCOT (22) LIMITED | 15 abr 1996 | 15 abr 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RBS MEZZANINE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RBS MEZZANINE LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 jun 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RBS MEZZANINE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Nombramiento de Andrew Tackaberry como director el 01 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keith Damian Pereira como director el 01 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ Scotland a 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH el 14 mar 2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2022 au 30 jun 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Luke Esrom Roberts el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Keith Damian Pereira el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 24/25 st Andrew Square Edinburgh EH2 1AF a Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ el 22 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Notification de N.C. Head Office Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Modification des détails de Natwest Markets Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 15 jul 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RBS MEZZANINE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| ROBERTS, Luke Esrom | Director | Castle Street EH2 3AH Edinburgh 7 | England | Irish | 228724900001 | |||||||||
| TACKABERRY, Andrew | Director | Castle Street EH2 3AH Edinburgh 7 | England | Irish | 241225430001 | |||||||||
| CASTRO, Marcos | Secretario | 2b St Johns Road RH1 6HF Redhill Surrey | Other | 109248350003 | ||||||||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Secretario | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Secretario | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||||||
| MILLS, Alan Ewing | Secretario | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Secretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| BOAG, Timothy John Donald | Director | 23 St Georges Road St Margaret's TW1 1QS East Twickenham Middlesex | England | British | 62111350003 | |||||||||
| CAMERON, John Alastair Nigel | Director | 36 St Andrews Square EH2 2YB Edinburgh Midlothian | British | 112570840001 | ||||||||||
| CAMPBELL, Hew | Director | 44 Castleknowe Gardens Kirkton Park ML8 5UX Carluke Scotland | British | 1416100007 | ||||||||||
| CATO, Guy Howard | Director | 135 Bishopsgate EC2M 3UR London 7th Floor England | England | British | 167340790001 | |||||||||
| CLARK, William James | Director | 24 Ladbroke Walk W11 3PW London | England | British | 32776440001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Director | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 England | United Kingdom | British | 148842310001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Director | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| GREENSHIELDS, John Fraser | Director | Highfield House The Lane TN3 0RP Fordcombe Kent | British | 62806730003 | ||||||||||
| GRIMSHAW, Helen Ann, Director | Director | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | 197010670001 | |||||||||
| HAMILTON, Euan Graeme | Director | 1b Saint Ninians Road EH12 8AP Edinburgh | Scotland | Scottish | 96880890001 | |||||||||
| HOURICAN, John Patrick | Director | 1077 VX Amsterdam Diepenbrockstraat 5 Netherlands | Irish | 77547010004 | ||||||||||
| IRISH, Matthew Edward Alphage | Director | London EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | 191076550001 | |||||||||
| JONES-MOLYNEUX, Darren Scott | Director | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | 152191300001 | |||||||||
| JORDAN, Nicholas Mark | Director | 43 Priory Road TW9 3DQ Kew Surrey | United Kingdom | British | 114291290001 | |||||||||
| LOUDEN, Philip Barry | Director | Sherwood First Avenue SS17 8AD Stanford Le Hope Essex | United Kingdom | English | 51088500001 | |||||||||
| MCLAREN, Bruce James | Director | 35 Strawberry Vale TW1 4RX Twickenham Middlesex | England | British | 4664930004 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Director | EC2M 4AA London 250, Bishopsgate England | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Director | Castle Street EH2 3AH Edinburgh 7 | England | British | 239981580001 | |||||||||
| ROBERTSON, Iain Leith Johnston | Director | 14 March Pines EH4 3PF Edinburgh | British | 52225140001 | ||||||||||
| ROBERTSON, Iain Samuel | Director | Northlands 22 Sandpit Lane AL1 4HL St Albans Hertfordshire | British | 7870930001 | ||||||||||
| SPEIRS, Robert | Director | 17 Kings Crescent G84 7RB Helensburgh Dunbartonshire | British | 2592770003 | ||||||||||
| STEVENS, James Alexander | Director | 28 Kettilstoun Crescent EH49 6PR Linlithgow West Lothian | British | 52588740002 | ||||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Director | 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedforedshire | England | British | 111421900001 | |||||||||
| THOMSON, Scott Mcfarlane | Director | 21a Pine Grove KT13 9AN Weybridge Surrey | England | British | 124244410001 | |||||||||
| TOUGH, Eric George William | Director | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | 54132470001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RBS MEZZANINE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. Head Office Nominees Limited | 15 jul 2020 | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Natwest Markets Plc | 06 abr 2016 | St Andrew Square EH2 2YB Edinburgh 36 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RBS MEZZANINE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0