NCM FUND SERVICES LIMITED

NCM FUND SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNCM FUND SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC166074
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NCM FUND SERVICES LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra NCM FUND SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Fourth Floor, 7
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NCM FUND SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NCM FINANCE LIMITED12 nov 200912 nov 2009
    NOBLE CORPORATE MANAGEMENT LIMITED22 dic 200522 dic 2005
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED30 sept 199630 sept 1996
    DUNWILCO (512) LIMITED04 jun 199604 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NCM FUND SERVICES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 nov 2025
    Próximas cuentas vencen el31 ago 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NCM FUND SERVICES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta26 mar 2026
    Próxima declaración de confirmación vence09 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta26 mar 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NCM FUND SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2024

    30 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 26 mar 2024

    3 páginasRP04CS01

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 26 mar 2022

    3 páginasRP04CS01

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 26 mar 2023

    3 páginasRP04CS01

    Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 26 mar 2021

    3 páginasRP04CS01

    Estado de capital el 13 mar 2025

    • Capital: GBP 20,000
    3 páginasSH19

    Estado de capital el 13 mar 2025

    • Capital: GBP 20,000
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Amound standing to the credit of the capital redemption reserve be cancelled 12/03/2025
    RES13

    Domicilio social registrado cambiado de Fourth Floor Castle Street Edinburgh EH2 3AH Scotland a Fourth Floor, 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH el 19 feb 2025

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 4th Floor, 7 Castle Street, Edinburgh Castle Street Edinburgh EH2 3AH Scotland a Fourth Floor Castle Street Edinburgh EH2 3AH el 27 ene 2025

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 26 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 nov 2023

    20 páginasAA

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 nov 2022

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Declaración de confirmación presentada el 26 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 nov 2021

    22 páginasAA

    Modification des détails de Chaplin Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 nov 2021

    2 páginasPSC05

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Error in submission of SH01 22/03/2021
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 26 mar 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 11 mar 2021

    • Capital: GBP 107.53
    3 páginasSH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 nov 2020

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de NCM FUND SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCLEAY, Kathleen Moir
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Secretario
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    149052720001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Director
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    United KingdomBritish63131640001
    GRAHAM, Douglas
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Director
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    ScotlandBritish162769630001
    MCLEAY, Kathleen Moir
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Director
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    ScotlandBritish146173660001
    SULLIVAN, James Alistair
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Director
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    United KingdomBritish126441710003
    CHURCHILL, Stephen
    13 (1f) Royal Terrace
    EH7 5AB Edinburgh
    Secretario
    13 (1f) Royal Terrace
    EH7 5AB Edinburgh
    British85739530002
    PAGE, Louise
    2/2 Grosvenor Gardens
    EH5 5JU Edinburgh
    Secretario
    2/2 Grosvenor Gardens
    EH5 5JU Edinburgh
    British59177160003
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secretario designado corporativo
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secretario corporativo
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    ASHTON, Charles James
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    Director
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    United KingdomBritish139012420002
    COUTTS, Maureen Sheila
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Director designado
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004630001
    DONALDSON, David Graham
    Newmills House
    1 Newmills Road
    EH14 5AG Balerno
    Midlothian
    Director
    Newmills House
    1 Newmills Road
    EH14 5AG Balerno
    Midlothian
    ScotlandBritish1077140001
    GRANT, Adam Douglas Mortimer
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    Director
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish147687150001
    GRAVES, Adrian George
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    Director
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    EnglandUnited Kingdom36906810001
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Director designado
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    JESSOP, Alan Dixon
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    Director
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    British67849380002
    MACPHERSON, Angus Robert
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    Director
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    ScotlandBritish117526370001
    NASH, Ian Eric
    Mount Cottage
    Linden Chase
    TN13 3JT Sevenoaks
    Kent
    Director
    Mount Cottage
    Linden Chase
    TN13 3JT Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish11953390004
    NEWALL, Archibald Patrick
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    Director
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    British70430050001
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Director
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritish685750001
    PAGE, David Keith
    14b Drumsheugh Gardens
    EH3 7QG Edinburgh
    Director
    14b Drumsheugh Gardens
    EH3 7QG Edinburgh
    British84309420003
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Director
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    POKORA, David Bernard
    30 Pitchens End
    SN4 9PR Broad Hinton
    Wiltshire
    Director
    30 Pitchens End
    SN4 9PR Broad Hinton
    Wiltshire
    United KingdomBritish63190500001
    SMEATON, Robin Campbell
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Director
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandScottish2584040001
    SPEARMAN, Alexander Lochain
    Glenshochie
    PH1 4PX Stanley
    Perthshire
    Director
    Glenshochie
    PH1 4PX Stanley
    Perthshire
    British17991890002
    THOMSON, Benjamin John Paget
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    British44243290003
    THOMSON, Benjamin John Paget
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    British44243290003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NCM FUND SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Chaplin Finance Limited
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    06 abr 2016
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0