COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC167175 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Edinburgh House 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RBS COMPANY NOMINEES LIMITED | 11 mar 1997 | 11 mar 1997 |
| ROBOSCOT (2) NOMINEES LIMITED | 22 jul 1996 | 22 jul 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Christopher Pears como director el 28 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr George Richard Trevaskis como director el 28 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Llewellyn Kevan Botha como secretario el 25 ene 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Llewellyn Kevan Botha el 10 jul 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Christopher Pears el 22 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Llewellyn Kevan Botha el 06 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr Llewellyn Kevan Botha el 06 abr 2022 | 1 páginas | CH03 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 9 páginas | AA | ||
Nombramiento de Judith Mary Matthews como secretario el 01 dic 2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Dolbear como secretario el 23 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 9 páginas | AA | ||
Nombramiento de Leighton Peter Hazell-Smart como director el 31 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nazir Sarkar como director el 31 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de James Terence Hood como director el 31 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Christopher Pears como director el 31 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTHEWS, Judith Mary | Secretario | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | 290285360001 | |||||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | South African | 105560560002 | |||||
| HAZELL-SMART, Leighton Peter | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | British | 261140830001 | |||||
| TREVASKIS, George Richard | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | British | 327174080002 | |||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Secretario | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | South African | 105560560001 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Secretario | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | 83564940010 | ||||||
| DOLBEAR, Jonathan | Secretario | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | 161908490001 | |||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secretario | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||
| WALLACE, Barbara Charlotte | Secretario | 180 Springfield Road EH49 7JT Linlithgow West Lothian | British | 59091840002 | ||||||
| BRAASCH, Jochen | Director | Woodfield Road Redland BS6 6PL Bristol Apt Number 15, Chandos England | England | German | 153472260001 | |||||
| CAMPBELL, Hew | Director | 44 Castleknowe Gardens Kirkton Park ML8 5UX Carluke Scotland | British | 1416100007 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Director | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British | 83564940010 | |||||
| CROSBY, William Stuart | Director | 705 Tead Froad Shad Thames SE1 2AS London | Australian | 108743530001 | ||||||
| EVANS, Ian Andrew | Director | 3 Sandford Road Hotwells BS8 4QG Bristol | British | 50495320005 | ||||||
| GILCHRIST, David John | Director | 1 Hollybank Place East Calder EH53 0QW Livingston West Lothian | British | 51330970001 | ||||||
| HOOD, James Terence | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | Wales | British | 189833420002 | |||||
| HOOD, James Terence | Director | Redland Road BS6 6YA Bristol 140b Avon United Kingdom | England | British | 189833420001 | |||||
| HUDD, David John | Director | 2 The Barton Hanham BS15 3LW Bristol Avon | England | British | 84292790001 | |||||
| MCKEAN, Alan Wallace | Director | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | 1019950002 | ||||||
| MILLS, Christopher Andrew | Director | Park Lane, Blagdon BS40 7SB Bristol Heronmere England | England | British | 178211930001 | |||||
| MORRIS, Christopher John | Director | 123 Beaconsfield Parade 3206 Albert Park Unit 10 Australia | Australia | Australian | 167662610001 | |||||
| MORRISON, Thomas Vance | Director | 17 East Barnton Gardens EH4 6AR Edinburgh | British | 1024220002 | ||||||
| OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert | Director | Lineburn Hill Chew Magna BS40 8QR Bristol Greenleigh Farm Holt United Kingdom | United Kingdom | British | 116701010002 | |||||
| OWEN, John William | Director | Little Green Cottage Little Green Easton BA5 1AU Wells Somerset | England | British | 59069620001 | |||||
| PEARS, Christopher | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | British | 261112330002 | |||||
| SARKAR, Nazir | Director | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | United States | British | 157131040016 | |||||
| SARLING, Barry Eric | Director | 1 Springfield Road Portishead BS20 9LH Bristol | British | 52848370001 | ||||||
| SMITH, Carlton John | Director | 5 Copley Court Hanham BS15 3SH Bristol | British | 52006900001 | ||||||
| SMITH, Jason Leigh | Director | 2 Providence Lane Long Ashton BS41 9DG Bristol | Australian | 115310950001 | ||||||
| STEWART, Colin Ross | Director | 66 Cammo Grove EH4 8HA Edinburgh Midlothian | British | 360200001 | ||||||
| STOCKDALE, Edward John | Director | Rock Villa, 18 Dundry Lane Winford BS40 8AW Bristol Avon | British | 65838060002 | ||||||
| TOUGH, Eric George William | Director | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | 54132470001 | ||||||
| WHITE, Steven Colin | Director | 158 Wheatfield Drive Bradley Stoke BS12 9DD Bristol | British | 52006970001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computershare Investor Services Plc | 08 abr 2016 | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0