COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED

COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC167175
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Edinburgh House
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RBS COMPANY NOMINEES LIMITED11 mar 199711 mar 1997
    ROBOSCOT (2) NOMINEES LIMITED22 jul 199622 jul 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2025
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 jul 2026
    Próxima declaración de confirmación vence04 ago 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 jul 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2025 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Pears como director el 28 feb 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr George Richard Trevaskis como director el 28 feb 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2024 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Llewellyn Kevan Botha como secretario el 25 ene 2024

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Llewellyn Kevan Botha el 10 jul 2023

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Christopher Pears el 22 abr 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Llewellyn Kevan Botha el 06 abr 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Llewellyn Kevan Botha el 06 abr 2022

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    9 páginasAA

    Nombramiento de Judith Mary Matthews como secretario el 01 dic 2021

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jonathan Dolbear como secretario el 23 jul 2021

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    9 páginasAA

    Nombramiento de Leighton Peter Hazell-Smart como director el 31 jul 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nazir Sarkar como director el 31 jul 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Terence Hood como director el 31 jul 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Christopher Pears como director el 31 jul 2019

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MATTHEWS, Judith Mary
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Secretario
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    290285360001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    EnglandSouth African105560560002
    HAZELL-SMART, Leighton Peter
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    EnglandBritish261140830001
    TREVASKIS, George Richard
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    EnglandBritish327174080002
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Secretario
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    South African105560560001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Secretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British83564940010
    DOLBEAR, Jonathan
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Secretario
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    161908490001
    MACGILLIVRAY, Shirley Margaret
    52 Erskine Road
    EH52 6XL Broxburn
    West Lothian
    Secretario
    52 Erskine Road
    EH52 6XL Broxburn
    West Lothian
    British40027890001
    WALLACE, Barbara Charlotte
    180 Springfield Road
    EH49 7JT Linlithgow
    West Lothian
    Secretario
    180 Springfield Road
    EH49 7JT Linlithgow
    West Lothian
    British59091840002
    BRAASCH, Jochen
    Woodfield Road
    Redland
    BS6 6PL Bristol
    Apt Number 15, Chandos
    England
    Director
    Woodfield Road
    Redland
    BS6 6PL Bristol
    Apt Number 15, Chandos
    England
    EnglandGerman153472260001
    CAMPBELL, Hew
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    Director
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    British1416100007
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish83564940010
    CROSBY, William Stuart
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Director
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Australian108743530001
    EVANS, Ian Andrew
    3 Sandford Road
    Hotwells
    BS8 4QG Bristol
    Director
    3 Sandford Road
    Hotwells
    BS8 4QG Bristol
    British50495320005
    GILCHRIST, David John
    1 Hollybank Place
    East Calder
    EH53 0QW Livingston
    West Lothian
    Director
    1 Hollybank Place
    East Calder
    EH53 0QW Livingston
    West Lothian
    British51330970001
    HOOD, James Terence
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    WalesBritish189833420002
    HOOD, James Terence
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    Director
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritish189833420001
    HUDD, David John
    2 The Barton
    Hanham
    BS15 3LW Bristol
    Avon
    Director
    2 The Barton
    Hanham
    BS15 3LW Bristol
    Avon
    EnglandBritish84292790001
    MCKEAN, Alan Wallace
    141 Colinton Road
    EH14 1BG Edinburgh
    Director
    141 Colinton Road
    EH14 1BG Edinburgh
    British1019950002
    MILLS, Christopher Andrew
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    Director
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    EnglandBritish178211930001
    MORRIS, Christopher John
    123 Beaconsfield Parade
    3206 Albert Park
    Unit 10
    Australia
    Director
    123 Beaconsfield Parade
    3206 Albert Park
    Unit 10
    Australia
    AustraliaAustralian167662610001
    MORRISON, Thomas Vance
    17 East Barnton Gardens
    EH4 6AR Edinburgh
    Director
    17 East Barnton Gardens
    EH4 6AR Edinburgh
    British1024220002
    OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert
    Lineburn Hill
    Chew Magna
    BS40 8QR Bristol
    Greenleigh Farm Holt
    United Kingdom
    Director
    Lineburn Hill
    Chew Magna
    BS40 8QR Bristol
    Greenleigh Farm Holt
    United Kingdom
    United KingdomBritish116701010002
    OWEN, John William
    Little Green Cottage Little Green
    Easton
    BA5 1AU Wells
    Somerset
    Director
    Little Green Cottage Little Green
    Easton
    BA5 1AU Wells
    Somerset
    EnglandBritish59069620001
    PEARS, Christopher
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    EnglandBritish261112330002
    SARKAR, Nazir
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    Director
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    Scotland
    United StatesBritish157131040016
    SARLING, Barry Eric
    1 Springfield Road
    Portishead
    BS20 9LH Bristol
    Director
    1 Springfield Road
    Portishead
    BS20 9LH Bristol
    British52848370001
    SMITH, Carlton John
    5 Copley Court
    Hanham
    BS15 3SH Bristol
    Director
    5 Copley Court
    Hanham
    BS15 3SH Bristol
    British52006900001
    SMITH, Jason Leigh
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Director
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Australian115310950001
    STEWART, Colin Ross
    66 Cammo Grove
    EH4 8HA Edinburgh
    Midlothian
    Director
    66 Cammo Grove
    EH4 8HA Edinburgh
    Midlothian
    British360200001
    STOCKDALE, Edward John
    Rock Villa, 18 Dundry Lane
    Winford
    BS40 8AW Bristol
    Avon
    Director
    Rock Villa, 18 Dundry Lane
    Winford
    BS40 8AW Bristol
    Avon
    British65838060002
    TOUGH, Eric George William
    4 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    Director
    4 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    British54132470001
    WHITE, Steven Colin
    158 Wheatfield Drive
    Bradley Stoke
    BS12 9DD Bristol
    Director
    158 Wheatfield Drive
    Bradley Stoke
    BS12 9DD Bristol
    British52006970001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    08 abr 2016
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3498808
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0