KINLY LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKINLY LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC167635
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KINLY LTD?

    • Comercio al por mayor de equipos y componentes electrónicos y de telecomunicaciones (46520) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
    • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra KINLY LTD?

    Dirección de la sede social
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KINLY LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VIJU LTD31 oct 201231 oct 2012
    CITY INFORMATION SERVICES LIMITED17 dic 199617 dic 1996
    MBM (154) LIMITED12 ago 199612 ago 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KINLY LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KINLY LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    17 páginasLIQ13(Scot)

    Cese del nombramiento de Ian Grant Wallace como secretario el 31 dic 2020

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ian Grant Wallace como director el 31 dic 2020

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 6 Fleming Road Kirkton Campus Livingston West Lothian EH54 7BN Scotland a 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX el 15 dic 2020

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 dic 2020

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    28/08/2020
    RES13

    Estado de capital el 27 ago 2020

    • Capital: GBP 1.20
    6 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    legacy

    2 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share pemium account and capital redemption reserve of the company be cancelled 26/08/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Leighton Hughes como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    36 páginasAA

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC08

    Cessation de Albertus Frederik Tulp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 ene 2019

    1 páginasPSC07

    Cancelación total de la carga SC1676350005

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Freddy Dijkman como director el 24 feb 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Freddy Dijkman como director el 31 dic 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Thomas Michael Martin como director el 31 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Freddy Dijkman como director el 31 dic 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robbert Paul Bakker como director el 01 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    35 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KINLY LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAKKER, Robbert Paul, Mr.
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4 Atlantic Quay
    Director
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4 Atlantic Quay
    NetherlandsDutch263178780001
    MARTIN, Thomas Michael, Mr.
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4 Atlantic Quay
    Director
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4 Atlantic Quay
    NorwayIrish266610890001
    HOUSTON, Donald John
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Secretario
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    British45207780002
    WALLACE, Ian Grant
    24 Wellview Lane
    Murieston
    EH54 9HU Livingston
    West Lothian
    Secretario
    24 Wellview Lane
    Murieston
    EH54 9HU Livingston
    West Lothian
    British26414490002
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Secretario corporativo
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    42680350001
    BENTZEN, Knut Erik
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    NorwayNorwegian196121020001
    BROWN, Alexander David
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    Director
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    EnglandBritish156537680001
    CLARK, Colin Norman
    21 Haberlea Avenue
    South Park Village
    G53 7UZ Glasgow
    Director
    21 Haberlea Avenue
    South Park Village
    G53 7UZ Glasgow
    ScotlandBritish76214140002
    DIJKMAN, Freddy
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    NetherlandsDutch251138160001
    DIJKMAN, Freddy
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    NetherlandsDutch251138160001
    DOYLE, Eamonn
    The Carthouse
    Dykedale Farm
    FK15 0JU Dunblane
    Director
    The Carthouse
    Dykedale Farm
    FK15 0JU Dunblane
    ScotlandScottish90396910002
    EKEROT, Lars Magnus
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    NetherlandsSwedish244625660001
    EVANS, Andrew John
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    EnglandBritish172849650001
    GILL, Stephen Mark
    53 Heath Road
    Holtspur
    HP9 1DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    53 Heath Road
    Holtspur
    HP9 1DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish180110730001
    HEARD, Ian Paul
    Lorne Court - Flat 8
    51 Putney Hill, Putney
    SW15 7RX London
    Director
    Lorne Court - Flat 8
    51 Putney Hill, Putney
    SW15 7RX London
    British104681830001
    HELLAND, Kurt Steinar
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    Director
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    NorwayNorwegian150782400001
    HOUSTON, Donald John
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Director
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    ScotlandBritish45207780002
    HUGHES, Leighton
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    EnglandBritish254204910001
    JENSEN, Per Arne
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    Director
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    NorwayNorwegian240850900001
    JENSEN, Rune
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    Director
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    NorwayNorwegian180594590001
    JENSEN, Rune
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    Director
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    NorwayNorwegian196939260001
    LAVELLE, Benjamin
    36 Broadhurst Avenue
    M27 8EZ Manchester
    Manchester
    Director
    36 Broadhurst Avenue
    M27 8EZ Manchester
    Manchester
    British76312470001
    MCGHEE, Brian William Craighead
    The Lodge Bonaly Tower
    Colinton
    EH13 0PB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    The Lodge Bonaly Tower
    Colinton
    EH13 0PB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish48287540001
    ROWETT, Geoffrey David
    35 Allen House Park
    Hook Heath
    GU22 0DB Woking
    Surrey
    Director
    35 Allen House Park
    Hook Heath
    GU22 0DB Woking
    Surrey
    British58991930002
    STEVENSON, Robert
    77 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Director
    77 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British58793290001
    THOMPSON, John Noel
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    Director
    3 Baird Road, Kirkton Campus
    Livingston
    EH54 7AZ West Lothian
    ScotlandBritish30865950003
    WADE, Gareth John
    8/10 West Silvermills Lane
    EH3 5BD Edinburgh
    Director
    8/10 West Silvermills Lane
    EH3 5BD Edinburgh
    British76312440002
    WALLACE, Ian Grant
    24 Wellview Lane
    Murieston
    EH54 9HU Livingston
    West Lothian
    Director
    24 Wellview Lane
    Murieston
    EH54 9HU Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish26414490002
    WEIBELL, Roger Johnsen
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    NorwayNorwegian196121100001
    ØSTLIE, Odd Sverre
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    NorwayNorwegian185112970001
    MBM BOARD NOMINEES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    Director corporativo
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    42680340001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KINLY LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Albertus Frederik Tulp
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    11 sept 2017
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Nacionalidad: Dutch
    País de residencia: Netherlands
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Rune Jensen
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    06 abr 2016
    Fleming Road
    Kirkton Campus
    EH54 7BN Livingston
    6
    West Lothian
    Scotland
    Nacionalidad: Norwegian
    País de residencia: Norway
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para KINLY LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    05 jul 2019La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene KINLY LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 22 dic 2017
    Entregado el 04 ene 2018
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cooperatieve Rabobank U.A. (As Security Agent)
    Transacciones
    • 04 ene 2018Registro de una carga (MR01)
    • 04 ene 2018Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 05 jun 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 27 abr 2010
    Entregado el 14 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 may 2010Registro de un cargo (MG01s)
    • 04 ene 2018Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 oct 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 29 jun 2001
    Entregado el 04 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Scottish Enterprise
    Transacciones
    • 04 jul 2001Registro de un cargo (410)
    • 12 jul 2001Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 29 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 04 feb 1998
    Entregado el 13 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 feb 1998Registro de un cargo (410)
    • 18 jul 2001Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 04 ene 2018Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 22 may 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 10 ene 1997
    Entregado el 17 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 17 ene 1997Registro de un cargo (410)
    • 15 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene KINLY LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 jun 2023Fecha prevista de disolución
    11 dic 2020Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0