SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC169996 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Edinburgh Airport Turnhouse Road EH12 9DN Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EXECAIR (SCOTLAND) LIMITED | 20 nov 1996 | 20 nov 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr. Robert Bradley Williams como director el 31 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Angus Smith como director el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | 39 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 101 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Bba Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||||||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023 | 38 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
legacy | 99 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 dic 2023
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2022 | 34 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 103 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs. Maria Garton como secretario el 27 jun 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Don Griffin como director el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARTON, Maria, Mrs. | Secretario | Turnhouse Road EH12 9DN Edinburgh Edinburgh Airport Scotland | 310699810001 | |||||||
| ESHOO, Michael Peter, Mr. | Director | Turnhouse Road EH12 9DN Edinburgh Edinburgh Airport Scotland | United States | American | 300194480001 | |||||
| NENDICK, Jonathan Nicholas, Mr. | Director | Percival Way London Luton Airport LU2 9PA Luton Terminal 1 Bedfordshire United Kingdom | England | British | 296534070001 | |||||
| WILLIAMS, Robert Bradley, Mr. | Director | Turnhouse Road EH12 9DN Edinburgh Edinburgh Airport Scotland | United States | American | 342472060001 | |||||
| BAKER, Rachel Dawn | Secretario | Appleby Gardens LU6 3DB Dunstable 1 Bedfordshire United Kingdom | British | 132609590003 | ||||||
| HALL, Gareth | Secretario | 210 Brooklands Road KT13 0RJ Weybridge Surrey | British | 126581500001 | ||||||
| HARNDEN, Philip | Secretario | 17 Bowden Road Sunninghill SL5 9NJ Ascot Berkshire | British | 56075440004 | ||||||
| HINGSTON, Paul Anthony | Secretario | 26 Knights Orchard HP1 3QA Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 87980040001 | ||||||
| SMYTH, Craig Allan Gibson | Secretario | The Copse, Ockham Road South East Horsley KT24 6SG Leatherhead Surrey | British | 58040980001 | ||||||
| HBJ SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 19 Ainslie Place EH3 6AU Edinburgh | 900015110001 | |||||||
| BEST, David Hugh | Director | 6 Cunningham Gardens PA6 7GA Houston Renfrewshire | British | 93679970001 | ||||||
| BOUWER, Peter John | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | England | British | 175773950002 | |||||
| BROOKS, David Robert | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | England | British | 121239110004 | |||||
| BUCHANAN, Gordon | Director | 1 The Terraces Lansdowne Road, Wimbledon Village SW20 8AP London | British | 75698750001 | ||||||
| COWIE, Andrew Jonathan Scott | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | United Kingdom | British | 265191540001 | |||||
| EASSON, John Robertson | Director | Crosby Farm Cottage Bride Isle Of Man | British | 58675610001 | ||||||
| FALLON, Shawn Christopher | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | United States | American | 254879400001 | |||||
| FREEMAN, Yvette Helen | Director | Wigmore Street W1U 1QY London 105 United Kingdom | United Kingdom | British | 210927030001 | |||||
| FREEMAN, Yvette Helen | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | England | British | 194958620001 | |||||
| GARDNER, Allan Paul | Director | Chasemoor Portsmouth Road GU26 6BZ Hindhead Surrey | England | British | 55942190002 | |||||
| GIBNEY, Joseph Laurence | Director | 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN | United Kingdom | United States Of America | 162041400003 | |||||
| GRIFFIN, Michael Don, Mr. | Director | Percival Way London Luton Airport LU2 9PA Luton Terminal 1 England | United States | American | 306415850001 | |||||
| HALL, Gareth | Director | 210 Brooklands Road KT13 0RJ Weybridge Surrey | British | 126581500001 | ||||||
| HASKINS, Elizabeth A | Director | 418 River Drive Debary Florida 32713 Usa | American | 102925970001 | ||||||
| INSTONE, Paul Robert | Director | 81 Leslie Road RH4 1PW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 23280070002 | |||||
| JOHNSTONE, Mark Robin | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | England | British | 172350530001 | |||||
| JOHNSTONE, Mark | Director | 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN | Usa | British | 139372400002 | |||||
| KING, Kathleen | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | England | United States | 178883100001 | |||||
| LEE, Stephen | Director | 2071 Mohican Trail Maitland 32751 Florida Usa | British | 90754890002 | ||||||
| MACDONALD, Alexander Joseph | Director | 4 Stanely Drive PA2 6HE Paisley Renfrewshire | Scotland | British | 75479240001 | |||||
| MACMILLAN, Ian Clive | Director | 33 Dreghorn EH13 0DF Loan Edinburgh | United Kingdom | British | 156927150001 | |||||
| MARCHANT, Guy Stephen | Director | 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN | England | British | 162039480002 | |||||
| PARK, Graeme | Director | Flat 4, 19 Shepherds Hill N6 5QJ London | British | 100446460001 | ||||||
| PEARSE, Pat | Director | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor | England | British | 175524860002 | |||||
| REDMOND, John Joseph | Director | 10 Gomer Gardens TW11 9AT Teddington Middlesex | Irish | 75479230001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SIGNATURE FLIGHT SUPPORT UK REGIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature Aviation Limited | 06 abr 2016 | Percival Way London Luton Airport LU2 9PA Luton Terminal 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0