STRATHTAY VENTURES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STRATHTAY VENTURES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC171237 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STRATHTAY VENTURES LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 George Square G2 1AL Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRAVEHEART VENTURES LIMITED | 22 ene 1997 | 22 ene 1997 |
| NEWCO (507) LIMITED | 07 ene 1997 | 07 ene 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019 | 23 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 77 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Braveheart Investment Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Gbac Limited como secretario el 01 feb 2018 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Dundee Road Perth PH2 7DW a 1 George Square Glasgow G2 1AL el 11 nov 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeremy Delmar-Morgan como director el 31 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Charles Byars Thomson como director el 19 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Vivian David Hallam como director el 09 nov 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Merlin House Necessity Brae Perth PH2 0PF a 2 Dundee Road Perth PH2 7DW el 22 jun 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carolyn Smith como director el 06 may 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Aileen Brown como director el 20 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBAC LIMITED | Secretario corporativo | 83-85 Shambles Street S70 2SB Barnsley Old Linen Court England |
| 170866550001 | ||||||||||
| HALLAM, Vivian David | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | England | British | 91949990002 | |||||||||
| BALFOUR, Alan John | Secretario | Carpow House KY14 6EN Newburgh Fife | British | 949930002 | ||||||||||
| BROWN, Aileen | Secretario | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | 166522140001 | |||||||||||
| GRANT, Colin Craigie | Secretario | The Cherrybank Centre Cherrybank Gardens PH2 0PF Perth | British | 188230360001 | ||||||||||
| SMITH, Carolyn | Secretario | 2/3, 2 Walmer Crescent G51 1AT Glasgow | British | 90876900001 | ||||||||||
| THOMSON, Geoffrey Charles Byars | Secretario | Thorngreen Farm PH2 6HW Kinrossie By Perth | British | 18668020001 | ||||||||||
| THOMSON, William Gordon | Secretario | Easter Caputh Farm Cottage Murthly PH1 4LA Perthshire | British | 96912680001 | ||||||||||
| THREIPLAND, Andrew Murray | Secretario | Fingask PH2 7SA Rait Perthshire | British | 11753830002 | ||||||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh | 42680350001 | |||||||||||
| BALFOUR, Alan John | Director | Carpow House KY14 6EN Newburgh Fife | Scotland | British | 949930002 | |||||||||
| BAXTER, Edward Thomas | Director | Gilston KY8 5QP Leven Fife | Scotland | British | 36600150001 | |||||||||
| BENSON, Matthew James | Director | The Coach House Balgone EH39 5BP North Berwick East Lothian | British | 30332650003 | ||||||||||
| BOGGS, Peter Lawson | Director | 2 Cheyne Walk Chelsea SW3 5QZ London | American | 72417090001 | ||||||||||
| BROWN, Aileen | Director | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | Scotland | British | 135871560003 | |||||||||
| BROWN, John Kenneth | Director | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | Scotland | British | 462890004 | |||||||||
| CAMPBELL, Kenneth James | Director | 123 Craigentinny Avenue EH7 6RG Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 842260002 | |||||||||
| CAMPBELL FRASER, Patrick Alexander | Director | Borthwickshiels TD9 7LS Hawick Scottish Borders Scotland | Scotland | British | 49441240001 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Edward Brandwood | Director | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | United Kingdom | British | 376910001 | |||||||||
| DELMAR-MORGAN, Jeremy | Director | Dundee Road PH2 7DW Perth 2 Scotland | United Kingdom | British | 23953030001 | |||||||||
| GRANT, Colin Craigie | Director | The Cherrybank Centre Cherrybank Gardens PH2 0PF Perth | United Kingdom | British | 188230360001 | |||||||||
| HUGHES, James Michael | Director | Kerseland Crook Of Devon KY13 0UL Kinross Kinross Shire | Scotland | British | 107865020001 | |||||||||
| MACASKILL, Alistair Angus | Director | Beech Hill Beech Hill Road Coupar Angus PH13 9AZ Blairgowrie Perthshire | British | 49154730001 | ||||||||||
| MACPHERSON, Agnes Lawrie Addie Shonaig | Director | Lochcote EH49 6QE Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 104298000001 | |||||||||
| SMITH, Carolyn | Director | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | United Kingdom | British | 90876900001 | |||||||||
| STEWART, Robert Douglas | Director | Hilton Of Gask PH3 1HN Auchterarder Perthshire | British | 51913570002 | ||||||||||
| THOMSON, Geoffrey Charles Byars | Director | Dundee Road PH2 7DW Perth 2 Scotland | Perth | British | 18668020001 | |||||||||
| THOMSON, William Gordon | Director | Easter Caputh Farm Cottage Murthly PH1 4LA Perthshire | United Kingdom | British | 96912680001 | |||||||||
| THREIPLAND, Andrew Murray | Director | Fingask PH2 7SA Rait Perthshire | United Kingdom | British | 11753830002 | |||||||||
| TURNER, Donald Ian | Director | 10 The Glebe KA1 5PF Symington Ayrshire | Scotland | British | 172904550001 | |||||||||
| WATSON, Garry Sanderson | Director | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | England | British | 34442460001 | |||||||||
| WATSON, Garry Sanderson | Director | Newlandburn House Newlandrig EH23 4NS Gorebridge Midlothian | England | British | 34442460001 | |||||||||
| WEMYSS, Charles John | Director | Hill Of Invermay PH2 9DA Forgandenny Perthshire | United Kingdom | British | 732870002 | |||||||||
| WEMYSS, Michael James | Director | Wemyss Castle KY1 4TE Fife | United Kingdom | British | 227540002 | |||||||||
| MBM BOARD NOMINEES LIMITED | Director corporativo | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh Midlothian | 42680340001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braveheart Investment Group Plc | 06 abr 2016 | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene STRATHTAY VENTURES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 21 mar 2001 Entregado el 09 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0