STRATHTAY VENTURES LIMITED

STRATHTAY VENTURES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTRATHTAY VENTURES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC171237
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BRAVEHEART VENTURES LIMITED22 ene 199722 ene 1997
    NEWCO (507) LIMITED07 ene 199707 ene 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019

    23 páginasAA

    legacy

    77 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Braveheart Investment Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2019

    2 páginasPSC05

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    25 páginasAA

    Nombramiento de Gbac Limited como secretario el 01 feb 2018

    2 páginasAP04

    Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 2 Dundee Road Perth PH2 7DW a 1 George Square Glasgow G2 1AL el 11 nov 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    24 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jeremy Delmar-Morgan como director el 31 jul 2016

    1 páginasTM01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 07 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2016

    Estado de capital el 08 ene 2016

    • Capital: GBP 1,939,190
    SH01

    Cese del nombramiento de Geoffrey Charles Byars Thomson como director el 19 nov 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    27 páginasAA

    Nombramiento de Mr Vivian David Hallam como director el 09 nov 2015

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Merlin House Necessity Brae Perth PH2 0PF a 2 Dundee Road Perth PH2 7DW el 22 jun 2015

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Carolyn Smith como director el 06 may 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Aileen Brown como director el 20 abr 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GBAC LIMITED
    83-85 Shambles Street
    S70 2SB Barnsley
    Old Linen Court
    England
    Secretario corporativo
    83-85 Shambles Street
    S70 2SB Barnsley
    Old Linen Court
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro04246760
    170866550001
    HALLAM, Vivian David
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Director
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    EnglandBritish91949990002
    BALFOUR, Alan John
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    Secretario
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    British949930002
    BROWN, Aileen
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Secretario
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    166522140001
    GRANT, Colin Craigie
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    Secretario
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    British188230360001
    SMITH, Carolyn
    2/3, 2 Walmer Crescent
    G51 1AT Glasgow
    Secretario
    2/3, 2 Walmer Crescent
    G51 1AT Glasgow
    British90876900001
    THOMSON, Geoffrey Charles Byars
    Thorngreen Farm
    PH2 6HW Kinrossie By Perth
    Secretario
    Thorngreen Farm
    PH2 6HW Kinrossie By Perth
    British18668020001
    THOMSON, William Gordon
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    Secretario
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    British96912680001
    THREIPLAND, Andrew Murray
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    Secretario
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    British11753830002
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Secretario corporativo
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    42680350001
    BALFOUR, Alan John
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    Director
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    ScotlandBritish949930002
    BAXTER, Edward Thomas
    Gilston
    KY8 5QP Leven
    Fife
    Director
    Gilston
    KY8 5QP Leven
    Fife
    ScotlandBritish36600150001
    BENSON, Matthew James
    The Coach House
    Balgone
    EH39 5BP North Berwick
    East Lothian
    Director
    The Coach House
    Balgone
    EH39 5BP North Berwick
    East Lothian
    British30332650003
    BOGGS, Peter Lawson
    2 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5QZ London
    Director
    2 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5QZ London
    American72417090001
    BROWN, Aileen
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Director
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    ScotlandBritish135871560003
    BROWN, John Kenneth
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Director
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    ScotlandBritish462890004
    CAMPBELL, Kenneth James
    123 Craigentinny Avenue
    EH7 6RG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    123 Craigentinny Avenue
    EH7 6RG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish842260002
    CAMPBELL FRASER, Patrick Alexander
    Borthwickshiels
    TD9 7LS Hawick
    Scottish Borders
    Scotland
    Director
    Borthwickshiels
    TD9 7LS Hawick
    Scottish Borders
    Scotland
    ScotlandBritish49441240001
    CUNNINGHAM, Edward Brandwood
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Director
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish376910001
    DELMAR-MORGAN, Jeremy
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    Director
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    United KingdomBritish23953030001
    GRANT, Colin Craigie
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    Director
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    United KingdomBritish188230360001
    HUGHES, James Michael
    Kerseland
    Crook Of Devon
    KY13 0UL Kinross
    Kinross Shire
    Director
    Kerseland
    Crook Of Devon
    KY13 0UL Kinross
    Kinross Shire
    ScotlandBritish107865020001
    MACASKILL, Alistair Angus
    Beech Hill Beech Hill Road
    Coupar Angus
    PH13 9AZ Blairgowrie
    Perthshire
    Director
    Beech Hill Beech Hill Road
    Coupar Angus
    PH13 9AZ Blairgowrie
    Perthshire
    British49154730001
    MACPHERSON, Agnes Lawrie Addie Shonaig
    Lochcote
    EH49 6QE Linlithgow
    West Lothian
    Director
    Lochcote
    EH49 6QE Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritish104298000001
    SMITH, Carolyn
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Director
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish90876900001
    STEWART, Robert Douglas
    Hilton Of Gask
    PH3 1HN Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Hilton Of Gask
    PH3 1HN Auchterarder
    Perthshire
    British51913570002
    THOMSON, Geoffrey Charles Byars
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    Director
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    PerthBritish18668020001
    THOMSON, William Gordon
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    Director
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    United KingdomBritish96912680001
    THREIPLAND, Andrew Murray
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    Director
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    United KingdomBritish11753830002
    TURNER, Donald Ian
    10 The Glebe
    KA1 5PF Symington
    Ayrshire
    Director
    10 The Glebe
    KA1 5PF Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish172904550001
    WATSON, Garry Sanderson
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Director
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    EnglandBritish34442460001
    WATSON, Garry Sanderson
    Newlandburn House Newlandrig
    EH23 4NS Gorebridge
    Midlothian
    Director
    Newlandburn House Newlandrig
    EH23 4NS Gorebridge
    Midlothian
    EnglandBritish34442460001
    WEMYSS, Charles John
    Hill Of Invermay
    PH2 9DA Forgandenny
    Perthshire
    Director
    Hill Of Invermay
    PH2 9DA Forgandenny
    Perthshire
    United KingdomBritish732870002
    WEMYSS, Michael James
    Wemyss Castle
    KY1 4TE Fife
    Director
    Wemyss Castle
    KY1 4TE Fife
    United KingdomBritish227540002
    MBM BOARD NOMINEES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    Director corporativo
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    42680340001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Braveheart Investment Group Plc
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    06 abr 2016
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006 Scottish Law
    Lugar de registroRegister Of Companies Scotland
    Número de registroSc247376
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene STRATHTAY VENTURES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 21 mar 2001
    Entregado el 09 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 abr 2001Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0