SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED

SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC172022
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED?

    • Concesión de crédito por parte de entidades financieras no depositarias y otros otorgantes especializados de crédito al consumo (64921) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    G1, 5 George Square
    G2 1DY Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOUTHGATE RETAIL PARK LIMITED26 mar 199726 mar 1997
    PACIFIC SHELF 711 LIMITED04 feb 199704 feb 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    3 páginas4.26(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de 301 st Vincent Street Glasgow G2 5AB el 16 oct 2012

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 09 oct 2012

    LRESSP

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 feb 2012

    Estado de capital el 14 feb 2012

    • Capital: GBP 1,100,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Sandra Huckle como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    Cambio de datos del director Sandra Dawn Huckle el 05 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Andrew Moss el 15 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Michael John Merrick el 05 mar 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Andrew Moss como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kerr Luscombe como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael John Merrick como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    13 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Secretario corporativo
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    115204320002
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Director
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritishActuary74114060001
    MOSS, Andrew
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Director
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant151524430001
    COUPE, Ernest Peter
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    Secretario
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    British38314970001
    HENDERSON, Gordon
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishLife Assurance Official344750001
    MCEWAN, Allan David
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    Secretario
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishCompany Director51216260001
    RAMSAY, Caroline
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Secretary39851670003
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretario corporativo
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    MD SECRETARIES (EDINBURGH) LIMITED
    Pacific House
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Secretario corporativo
    Pacific House
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    43825370001
    ALI, Yacub
    Telfer House
    Garrion Bridge
    ML9 2UB Larkhall
    Director
    Telfer House
    Garrion Bridge
    ML9 2UB Larkhall
    BritishCompany Director2450001
    COLES, Shaun Patrick
    Chaplin Walk
    Great Cornard
    CO10 0YT Sudbury
    4
    Suffolk
    Director
    Chaplin Walk
    Great Cornard
    CO10 0YT Sudbury
    4
    Suffolk
    United KingdomBritishChartered Secretary95706540001
    COUPE, Ernest Peter
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    Director
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    BritishChartered Surveyor38314970001
    HENDERSON, Gordon
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishLife Assurance Official344750001
    HUCKLE, Sandra Dawn
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Director
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritishAccountant133348730001
    LINDSAY, Kenneth Fraser
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor121520410001
    LUSCOMBE, Kerr
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    Director
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director83541890001
    MACGARVIE, James Stuart
    22 Garden Street
    KA4 8HX Galston
    Ayrshire
    Director
    22 Garden Street
    KA4 8HX Galston
    Ayrshire
    BritishChartered Town Planning Ass'T.74305300001
    MACKIE, Colin Mathison
    5 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Director
    5 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    ScotlandBritishInvestment Director36377590001
    MCEWAN, Allan David
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    Director
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritishCompany Director51216260001
    MCLELLAN, William Lawrence
    56 Glenalla Crescent
    Alloway
    KA7 4DA Ayr
    Ayrshire
    Director
    56 Glenalla Crescent
    Alloway
    KA7 4DA Ayr
    Ayrshire
    BritishCompany Director4618630001
    PATERSON, John Edward
    23 Braeburn Drive
    EH14 6AQ Currie
    Midlothian
    Scotland
    Director
    23 Braeburn Drive
    EH14 6AQ Currie
    Midlothian
    Scotland
    BritishActuary59174260002
    POTTINGER, Graham Robert
    1 Gotter Bank
    Quarriers Village
    PA11 3NX Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Director
    1 Gotter Bank
    Quarriers Village
    PA11 3NX Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant33361050003
    RAMSAY, Caroline
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Secretary39851670003
    SINGLETON, Graham Lloyd
    High Meadow
    Alderminster
    CV37 8NX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    High Meadow
    Alderminster
    CV37 8NX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishManaging Director63550740005
    WATT, Charles
    Roseholm 7 Orchard Leigh
    St Nicholas Hill
    KT22 8NE Leatherhead
    Surrey
    Director
    Roseholm 7 Orchard Leigh
    St Nicholas Hill
    KT22 8NE Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director55295300001
    WOODS, David Ernest
    20 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Midlothian
    Director
    20 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishNone344760001
    WRIGHT, Jason Leslie
    Sandford Lodge
    21 Reading Road
    OX10 9DS Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    Sandford Lodge
    21 Reading Road
    OX10 9DS Wallingford
    Oxfordshire
    BritishCompany Secretary72145280003
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Director designado corporativo
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    ¿Tiene SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 07 jul 1997
    Entregado el 10 jul 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Plots and areas of ground at cathcart road and crown street,glasgow.
    Personas con derecho
    • Charterhouse Bank Limited
    Transacciones
    • 10 jul 1997Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 07 jul 1997
    Entregado el 10 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Plots and or areas of ground at cathcart road and crown street glasgow.
    Personas con derecho
    • Charterhouse Bank Limited
    Transacciones
    • 10 jul 1997Registro de un cargo (410)
    • 14 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 02 jul 1997
    Entregado el 04 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Charterhouse Bank Limited
    Transacciones
    • 04 jul 1997Registro de un cargo (410)
    • 14 jul 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 29 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 02 jun 1997
    Entregado el 11 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Area of ground to the northwest of crown street,glasgow.
    Personas con derecho
    • The Scottish Provident Institution
    Transacciones
    • 11 jun 1997Registro de un cargo (410)
    • 08 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 23 abr 1997
    Entregado el 24 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Scottish Provident Institution
    Transacciones
    • 24 abr 1997Registro de un cargo (410)
    • 14 jul 1997Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 14 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    ¿Tiene SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 mar 2014Fecha de disolución
    09 oct 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Profesional
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0