MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC173710 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Brodies Llp 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jonathan David Forster el 31 mar 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Elizabeth Ann Horlock Clarke el 31 mar 2020 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ocean Point 1st Floor, 94 Ocean Drive Edinburgh EH6 6JH United Kingdom a C/O Brodies Llp 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA el 11 mar 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Morrison (Oldco) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 mar 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Modification des détails de Wave Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 sept 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ocean Point 1st Floor, Ocean 94 Ocean Drive Edinburgh Eh6 6 Jh United Kingdom a Ocean Point 1st Floor, 94 Ocean Drive Edinburgh EH6 6JH el 18 ene 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 47 Melville Street Edinburgh EH3 7HL a Ocean Point 1st Floor, Ocean 94 Ocean Drive Edinburgh Eh6 6 Jh el 18 ene 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Claire Tytherleigh Russell como director el 28 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Ann Horlock Clarke como director el 28 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Ann Horlock Clarke como director el 01 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Tytherleigh Russell como director el 30 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Arthur George Shepheard como secretario el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Secretario | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | 198551370001 | |||||||
| FORSTER, Jonathan David | Director | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House United Kingdom | United Kingdom | British | 101812460002 | |||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Director | 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh C/O Brodies Llp Scotland | England | British | 105433380001 | |||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Secretario | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Secretario | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||
| MORRISON, John | Secretario | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Secretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| TURNER, David Charles | Secretario | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Director | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 122463830003 | |||||
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Director | Melville Street EH3 7HL Edinburgh 47 | United Kingdom | British | 203580340001 | |||||
| FIRTH, Patrick | Director | The Cottage High Street PE28 0AB Ellington Huntingdon Cambs | British | 85034900001 | ||||||
| FORSTER, Jonathan David | Director | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 101812460002 | |||||
| GREEN, Robert David | Director | 1a Burnside Road White Craigs G46 6TT Glasgow | British | 76720550002 | ||||||
| HAMPSON, Michael David | Director | Anglian House Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Cambs | British | 105084640001 | ||||||
| HOWELL, Keith Martin | Director | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | 1499960006 | ||||||
| LAWSON, Robin Patrick | Director | 8 Drumsheugh Gardens EH3 7QJ Edinburgh | British | 11071830002 | ||||||
| MACLENNAN, Norman Angus | Director | Croft Na Coille 25 Toberargan Road PH16 5HG Pitlochry Perthshire | British | 75374210001 | ||||||
| MORRISON, John | Director | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||
| NILSSON, Lars Ingvar | Director | Stora Fiskaregatan 9e S 222 24 Lund FOREIGN Sweden | Swedish | 76837160001 | ||||||
| POPLE, David George | Director | 120 Stanley Street AB10 6UQ Aberdeen Aberdeenshire | British | 53727020004 | ||||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Director | Melville Street EH3 7HL Edinburgh 47 | England | British | 105433380001 | |||||
| SIMS, Christopher John | Director | Chartmoor Chart Lane Brasted Chart TN16 1LU Westerham Kent | British | 51887190001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Director | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 135181230001 | |||||
| WARRACK, Anne Victoria Mary | Director | The White Cottage 153 Bridge Street, Whddon SG8 5SP Royston Herts | United Kingdom | British | 123157220001 | |||||
| WATSON, Derek | Director | 68 Woodvale Coulby Newham TS8 0SJ Middlesbrough Cleveland | England | British | 6396340001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrison (Oldco) Limited | 06 abr 2016 | 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh C/O Brodies Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 17 jul 1997 Entregado el 01 ago 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole of the property. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 18 jun 1997 Entregado el 25 jun 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0