TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED

TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC175671
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TULLOCH HOMES GROUP LIMITED03 dic 199703 dic 1997
    TULLOCH HOMES (GROUP) LIMITED28 oct 199728 oct 1997
    TULLOCH HOMES (HOLDINGS) LIMITED23 sept 199723 sept 1997
    PACIFIC SHELF 732 LIMITED21 may 199721 may 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    12 páginasLIQ13(Scot)

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC08

    Cessation de Tulloch Homes (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 mar 2019

    1 páginasPSC07

    Domicilio social registrado cambiado de Stoneyfield House Stoneyfield Business Park Inverness IV2 7PA a 7-11 Melville Street Edinburgh EH3 7PE el 05 jul 2018

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 jun 2018

    LRESSP

    Cancelación total de la carga SC1756710006

    1 páginasMR04

    Cambio de datos del director Ian Macdonald el 27 jun 2018

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2017

    13 páginasAA

    legacy

    34 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2016

    13 páginasAA

    legacy

    35 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 abr 2016

    Estado de capital el 25 abr 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2015

    13 páginasAA

    legacy

    35 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cambio de datos del director Mr Alexander James Grant el 07 ene 2016

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FRASER, George Gabriel
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    ScotlandBritish50219540001
    GRANT, Alexander James
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    United KingdomBritish113195780003
    MACDONALD, Ian
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    ScotlandBritish81926330001
    CAMERON, James
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Secretario
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    British166632500001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Secretario
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    British145418810001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    Secretario
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    British87534020003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Secretario
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Director
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Director
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BRAZIER, Stephen Harvey
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100183520001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Director
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritish34848670001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Director
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritish34848670001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Director
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Director
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritish145418810001
    MACDOUGALL, Alasdair
    104 Culduthel Park
    IV2 4RZ Inverness
    Highland
    Director
    104 Culduthel Park
    IV2 4RZ Inverness
    Highland
    ScotlandBritish91007550001
    MACKENZIE, Donald Henry
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    Director
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish66483050001
    MACLENNAN, Fiona
    Steinnola
    7 Macleod Place
    IV15 9TZ Dingwall
    Ross Shire
    Director
    Steinnola
    7 Macleod Place
    IV15 9TZ Dingwall
    Ross Shire
    British45638410001
    MACRAE, Gordon Major Robson
    8 Drummond Crescent
    IV2 4QW Inverness
    Inverness Shire
    Director
    8 Drummond Crescent
    IV2 4QW Inverness
    Inverness Shire
    InvernessBritish19800001
    MARSHALL, Alyson
    8 Blackthorn Avenue
    G66 4BZ Kirkintilloch
    Lanarkshire
    Director
    8 Blackthorn Avenue
    G66 4BZ Kirkintilloch
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116919700001
    MCARTHUR, Robert Johnstone
    Almond House, 8 Burrell Street
    PH7 4DR Crieff
    Perthshire
    Director
    Almond House, 8 Burrell Street
    PH7 4DR Crieff
    Perthshire
    British81926300001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MELVILLE, Gordon
    19 Fishers Green
    FK9 4PU Bridge Of Allan
    Director
    19 Fishers Green
    FK9 4PU Bridge Of Allan
    British91539740001
    MONKS, Charles
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    Director
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    ScotlandBritish62550910001
    PETERS, Douglas
    8 Margaret Rose Loan
    EH10 7EQ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    8 Margaret Rose Loan
    EH10 7EQ Edinburgh
    Midlothian
    British108781900001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Director
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    TORRANCE, Susan Margaret
    Caberfeidh
    Upper Rosemount
    IV19 1ND Tain
    Highland
    Director
    Caberfeidh
    Upper Rosemount
    IV19 1ND Tain
    Highland
    United KingdomBritish91050230001
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Director
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    WRIGHT, Donald James
    Griannan
    St Leonards Road
    IV36 2RE Forres
    Moray
    Director
    Griannan
    St Leonards Road
    IV36 2RE Forres
    Moray
    ScotlandBritish75244500002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Director designado corporativo
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    06 abr 2016
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc277497
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    12 mar 2019La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 04 mar 2015
    Entregado el 06 mar 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 mar 2015Registro de una carga (MR01)
    • 29 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 16 dic 2009
    Entregado el 22 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Playing field to south of bent road, hamilton LAN197626 under exception- see form for further details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 dic 2009Registro de un cargo (MG01s)
    • 29 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 02 nov 2006
    Entregado el 16 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    That plot or area of ground extending to 0.164 hectares or thereby lying to the north west side of grampian road/main road aviemore being the B9152.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 nov 2006Registro de un cargo (410)
    • 05 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Standard security
    Creado el 10 feb 2003
    Entregado el 19 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    92 raeberry street, glasgow--title number GLA50417.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 feb 2003Registro de un cargo (410)
    • 05 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creado el 12 nov 1997
    Entregado el 19 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 nov 1997Registro de un cargo (410)
    • 06 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 jun 2018Inicio de la liquidación
    05 ago 2022Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0