ST ANDREW LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ST ANDREW LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC177533 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ST ANDREW LIMITED?
- (4521) /
¿Dónde se encuentra ST ANDREW LIMITED?
| Dirección de la sede social | Regency House Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Fife |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ST ANDREW LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BERKELEY ST ANDREW PUBLIC LIMITED COMPANY | 25 jul 1997 | 25 jul 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ST ANDREW LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST ANDREW LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 15 dic 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Norman Yardley el 08 jul 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 jul 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Norman Yardley como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 jul 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Gaffney como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ST ANDREW LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147808800001 | |||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| YARDLEY, Norman | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MACLENNAN, Angus | Secretario | Wellfield Cottage 32 Muirpark EH22 3JD Dalkeith Midlothian | British | 65238670001 | ||||||
| MILLER, Alasdair James | Secretario | 22 Beauly Crescent Newton Mearns G77 5UQ Glasgow | British | 200739750001 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Secretario | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| PARSLIFFE, Andrew John | Secretario | 7 Dupplin Terrace PH2 7DG Perth Perthshire | British | 67033440002 | ||||||
| PUTTERGILL, Claire | Secretario | 18 Alfred Road KT1 2UA Kingston Upon Thames Surrey | British | 49527970003 | ||||||
| ANDERSON STRATHERN WS | Secretario corporativo | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh Midlothian | 33516610001 | |||||||
| BURNESS LLP | Secretario corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| BURNESS SOLICITORS | Secretario designado corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| BROWN, Andrew | Director | 5 Strathcarron Way PA2 7AE Paisley Renfrewshire | Scotland | Scottish | 91209410001 | |||||
| COSTER, Gordon Knox | Director | Mossdale East Kilbride G74 4JG Glasgow 6 United Kingdom | British | 132919070001 | ||||||
| CROOK, James | Director | 34 Barnton Park Crescent EH4 6EP Edinburgh Midlothian | British | 67105710001 | ||||||
| DAVIDSON, Iain Cameron | Director | 8 Calderstones Drive Whalley BB7 9JB Clitheroe Lancashire | England | British | 95642050001 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOWNIE, David | Director | 6 Ellersley Manor 60 Campbell Avenue EH12 6DN Edinburgh Midlothian | British | 67105390001 | ||||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GUEST, Robin Martin | Director | Summerlea Ferntower Road PH7 3DH Crieff Perthshire | British | 18510650002 | ||||||
| HUTCHINSON, Geoffrey | Director | Rectory Lodge Kyre WR15 8RW Tenbury Wells Worcestershire | United Kingdom | British | 16644000004 | |||||
| JACOBS, John Richard | Director | 12 Priory Quay Quay Road BH23 1DR Christchurch Dorset | British | 64717470001 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEITCH, Gerald | Director | 24 Mary Fisher Crescent G82 1BF Dumbarton Dunbartonshire | British | 110231420001 | ||||||
| LEWIS, Roger St John Hulton | Director | Lower Mole House Tilt Road KT11 3HS Cobham Surrey | British | 30879310002 | ||||||
| MACLENNAN, Angus | Director | Wellfield Cottage 32 Muirpark EH22 3JD Dalkeith Midlothian | British | 65238670001 | ||||||
| MACLEOD, Angus Iain | Director | 81 Fereneze Avenue Clarkston G76 7RX Glasgow | Scotland | British | 57667380001 | |||||
| MAXWELL, Clive | Director | 12 Brairhill Avenue Dalgety Bay KY11 9UR Dunfermline Fife | British | 122157390001 | ||||||
| MCARTHUR, Alexander Nigel | Director | 138 King Charles Road KT5 8QN Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 1571200001 | |||||
| MOTION, Michelle Hunter | Director | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British | 78545300002 | |||||
| O'CALLAGHAN, Sean James | Director | 3 Golf Place DD8 4TY Kirriemuir Angus | British | 101412420001 | ||||||
| PUNLER, Keith Arthur | Director | Beaufield Middle Balado KY13 0NH Kinross Tayside | Scotland | British | 142078700006 |
¿Tiene ST ANDREW LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 14 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 08 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 13 abr 2004 Entregado el 21 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 3.87 hectares on south side of windygates road, north berwick ELN226 under exception. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 13 abr 2004 Entregado el 21 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Ground north of dalry road, edinburgh & south of distillery lane, haymarket, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 13 abr 2004 Entregado el 21 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Phase 1 of the development at kip village, inverkip, greenock REN105133 under exception. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 05 abr 2004 Entregado el 16 abr 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 10 nov 2003 Entregado el 28 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Obligations pursuant to missives dated 2 march 2000 (as amended) | |
Breve descripción Phase 1C, kip village, inverkip, greenock. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 11 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción 163-167 ingram street and 92 glassford street, glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 11 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción 159 ingram street and 97-101 hutcheson street, glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 11 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción 1.5 acres at pollok castle estate, newton mearns. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 11 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Phase I at kip village, inverkip. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 11 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Windygates road, traynor's brae, north berwick. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Power house, dalry road, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Plots a and b, mount tabor road, perth. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Subjects at coulter road, biggar, lanark. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Units 3, 12, 17 and 18 bishops wood, dunblane, perth. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 08 jun 2001 Entregado el 15 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the finance documents | |
Breve descripción Plot numbers 1 and 3 woodlea, dunblane, perth. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 25 may 2001 Entregado el 31 may 2001 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 26 feb 2001 Entregado el 12 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Obligations as contained in missives | |
Breve descripción Area of ground at kip village, inverkip, greenock. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0