GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED

GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC178615
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit C, Ground Floor, Cirrus Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Paisley
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WIMPEY HOMES EAST SCOTLAND LIMITED02 abr 200102 abr 2001
    MCLEAN HOMES EAST SCOTLAND LIMITED08 sept 199708 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence22 nov 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 30 sept 2025

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Sara Hollowell como director el 01 oct 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jennifer Canty como director el 30 sept 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Sara Hollowell como secretario el 01 oct 2025

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 21 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 21 sept 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 07 jul 2023

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 07 jul 2023

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    5 páginasAA

    Registro de la carga SC1786150024, creada el 22 mar 2021

    5 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOLLOWELL, Sara
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Secretario
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    340891250001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish330353690001
    HOLLOWELL, Sara
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Director
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    United KingdomBritish200486170001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    311035480001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147317680001
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Secretario
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    British32824200005
    CANTY, Jennifer
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Secretario
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    322297040001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Scotland Street
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Homestead
    Essex
    Secretario
    Scotland Street
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Homestead
    Essex
    Other135438270002
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Secretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    219912930001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    166109560001
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritish193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish113503830003
    ARMSTRONG, Karen Jean
    Beechmount Park
    EH12 5YT Edinburgh
    9
    Director
    Beechmount Park
    EH12 5YT Edinburgh
    9
    United KingdomBritish137938400001
    BRADY, Tracey Jaynne
    14 King Malcolm Close
    Kings Manor
    EH10 7JB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    14 King Malcolm Close
    Kings Manor
    EH10 7JB Edinburgh
    Midlothian
    British75721390004
    BROWN, Simon Christopher
    105 Woodfield Avenue
    EH13 0QR Edinburgh
    Mid-Lothian
    Director
    105 Woodfield Avenue
    EH13 0QR Edinburgh
    Mid-Lothian
    United KingdomBritish113724050001
    BURNS, William Rae
    8 Redhill Road
    Balloch
    G68 9AS Cumbernauld
    Glasgow
    Director
    8 Redhill Road
    Balloch
    G68 9AS Cumbernauld
    Glasgow
    British75721190001
    CANTY, Jennifer
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Director
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    United KingdomBritish322288120001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish125216670001
    CARR, Peter Anthony
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    Director
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish130306120001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish9684390001
    CUSHEN, Keith Morgan
    Buddleia Cottage
    High Street
    TW12 2SX Hampton
    Middlesex
    Director
    Buddleia Cottage
    High Street
    TW12 2SX Hampton
    Middlesex
    British37763770002
    FRAME, Martin Mcfarlane
    47 Victoria Street
    AB39 2LH Stonehaven
    Aberdeenshire
    Director
    47 Victoria Street
    AB39 2LH Stonehaven
    Aberdeenshire
    British105621870001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Director
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish257671040002
    JENKINS, Stephen Adrian
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    Director
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish49738660003
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34521340004
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Director
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish147233120001
    MILLER, Allan
    18 Ashburnham Gardens
    South Queensferry
    EH30 9LB Edinburgh
    Director
    18 Ashburnham Gardens
    South Queensferry
    EH30 9LB Edinburgh
    ScotlandBritish156679100001
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    British115863170001
    NAYSMITH, Michael Grieve
    Stonefield Cottage
    Durno, Pitcaple
    AB51 5EP Inverurie
    Aberdeenshire
    Director
    Stonefield Cottage
    Durno, Pitcaple
    AB51 5EP Inverurie
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish103528680001
    PALMER, David William
    23 Masonfield Avenue
    Balloch
    G68 9DW Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    23 Masonfield Avenue
    Balloch
    G68 9DW Cumbernauld
    Lanarkshire
    British107741940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1392762
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0