SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED

SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC178872
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED?

    • (8514) /

    ¿Dónde se encuentra SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HIGHFIELD HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED17 nov 199917 nov 1999
    ARGUS CARE (PERTH) LIMITED15 jul 199915 jul 1999
    BURNGOLD EIGHT LIMITED18 sept 199718 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr David Charles Lovett como director el 31 ago 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 31 ago 2012

    1 páginasTM01

    Notificación de la finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4(Scot)

    Notificación del acta de la reunión que aprueba el acuerdo voluntario de los acreedores

    4 páginas1.1(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor Unit 2 Stirling Scotland FK9 4TU el 20 ene 2012

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 18 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 sept 2011

    Estado de capital el 20 sept 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    29 páginasAA

    Nombramiento de Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 18 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Southern Cross Healthcare 193 - 199 Bath Street, Glasgow Lanarkshireg2 4Hu el 28 jul 2010

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Enter into various agreements 14/05/2010
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009

    26 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de un director

    2 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    15 feb 2010Inconsistency At the time of filing, this document appeared to be inconsistent with other information filed against the company. 2 x AP01 forms filed on 06/01/10 for the same officer - options to amend record would be to file either a TM01 or apply for rectification on a form PR02a. - JBS

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Director
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Director
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Secretario
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Shiela
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Secretario
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British82685570001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158661400001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secretario
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    BURNETT & REID
    15 Golden Square
    AB10 1WF Aberdeen
    Secretario corporativo
    15 Golden Square
    AB10 1WF Aberdeen
    39027620001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Director
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BROWN, Edward Massie
    Ferreira, 1a High Street
    AB31 5RP Banchory
    Kincardineshire
    Director
    Ferreira, 1a High Street
    AB31 5RP Banchory
    Kincardineshire
    British42592420002
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Director
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Director
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DOUGLAS, Keith Stirling
    16 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    Director
    16 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    British36422460003
    FOULKES, Kamma
    C/O Southern Cross Healthcare
    193 - 199
    Bath Street, Glasgow
    Lanarkshireg2 4hu
    Director
    C/O Southern Cross Healthcare
    193 - 199
    Bath Street, Glasgow
    Lanarkshireg2 4hu
    United KingdomBritish111188390002
    JOYCE, Anthony
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    Director
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    ScotlandBritish95693160002
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Director
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Director
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Director
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MACINTOSH, Michael
    C/O Southern Cross Healthcare
    193 - 199
    Bath Street, Glasgow
    Lanarkshireg2 4hu
    Director
    C/O Southern Cross Healthcare
    193 - 199
    Bath Street, Glasgow
    Lanarkshireg2 4hu
    United KingdomBritish137864880001
    MALHAM, Janette
    C/O Southern Cross Healthcare
    193 - 199
    Bath Street, Glasgow
    Lanarkshireg2 4hu
    Director
    C/O Southern Cross Healthcare
    193 - 199
    Bath Street, Glasgow
    Lanarkshireg2 4hu
    United KingdomBritish91088900004
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Director
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MATHESON, Angus Macrae
    21 Irvine Place
    AB10 6HA Aberdeen
    Director
    21 Irvine Place
    AB10 6HA Aberdeen
    British66797660001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Director
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Director
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Director
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Director
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Director
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Director
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, Roy Simpson
    Burns Cottage
    Cornhill
    AB45 2DL Banff
    Director
    Burns Cottage
    Cornhill
    AB45 2DL Banff
    British48267230001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Director
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Director
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Director
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    United KingdomBritish147997950001
    STEIN, Anthony Karl
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    Director
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    United KingdomBritish109518530001
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Director
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    ScotlandBritish138774840001

    ¿Tiene SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 03 nov 1999
    Entregado el 15 nov 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Area of ground lying ot the north of harley place, muirton, perth.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 15 nov 1999Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 03 nov 1999
    Entregado el 15 nov 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Area of ground lying to the west of birch crescent, in the parish of scone and county of perth.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 15 nov 1999Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 03 nov 1999
    Entregado el 15 nov 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The birches, comrie road, crieff, perthshire.
    Personas con derecho
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transacciones
    • 15 nov 1999Registro de un cargo (410)
    Bond & floating charge
    Creado el 14 oct 1999
    Entregado el 21 oct 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Nhp Securities (No.3) Limited
    Transacciones
    • 21 oct 1999Registro de un cargo (410)

    ¿Tiene SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES (PERTH) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0