ESEP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ESEP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC180138 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ESEP LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra ESEP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5th Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ESEP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EASTERN SCOTLAND EUROPEAN PARTNERSHIP LIMITED | 30 oct 1997 | 30 oct 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ESEP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ESEP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 13 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 13 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 30 oct 2015, aucune liste de membres fournie | 3 páginas | AR01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||
Nombramiento de Can Kostepen como director el 18 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de David Miller como director el 18 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nelson Campbell Gray como director el 13 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Joseph Crawford Noble el 13 jul 2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Gordon Mclaren como director el 26 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 30 oct 2014, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||
Registro de la carga SC1801380002, creada el 13 nov 2014 | 11 páginas | MR01 | ||
Cese del nombramiento de Elizabeth Kelly Cameron como director el 08 ago 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de John Franz Bachtler como director el 08 ago 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kenneth William Goodwin como director el 07 ago 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ESEP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom |
| 133157900001 | ||||||||||
| KOSTEPEN, Can | Director | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th | United Kingdom | Turkish | 201172450001 | |||||||||
| MILLER, David | Director | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th | United Kingdom | British | 201172200001 | |||||||||
| NOBLE, Joseph Crawford | Director | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th | United Kingdom | British | 92763790001 | |||||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom | 133157900001 | |||||||||||
| ALEXANDER, Catherine Margaret | Director | 18 Royal Circus EH3 6SS Edinburgh | British | 56469050001 | ||||||||||
| BACHTLER, John Franz, Professor | Director | Brownside Road Cambuslang G72 8NL Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | British | 93132650001 | |||||||||
| BALLANTYNE, Elaine | Director | 33 Beechwood Park EH54 5QH Uphall Station West Lothian | Scotland | British | 269081210001 | |||||||||
| BELFORD, Judith Alison Janet | Director | Sydney Cottage 4 Manse Lane DD8 5BW Kirriemuir Angus | British | 77505990001 | ||||||||||
| BOYLE, Nuala | Director | Flat 1/1, 159 Tantallon Road Shawlands G41 3LU Glasgow | British | 72616970002 | ||||||||||
| BROWN, Colin Campbell | Director | 35 Dudley Gardens EH6 4PR Edinburgh | British | 76398030001 | ||||||||||
| BURT, John Clark | Director | 27 Lawers Road Broughty Ferry DD5 3TQ Dundee | Scotland | British | 52500090002 | |||||||||
| BURT, John Clark | Director | 27 Lawers Road Broughty Ferry DD5 3TQ Dundee | Scotland | British | 52500090002 | |||||||||
| CAMERON, Elizabeth Kelly, Doctor | Director | 100 Cloch Road PA19 1YA Gourock | Scotland | British | 158465490001 | |||||||||
| CARRICK, Eddie | Director | 3 Woodlea Park Sauchie FK10 2UD Alloa Clackmannanshire | Scotland | British | 89899980001 | |||||||||
| FERGUSON, Matthew John | Director | 26 Dundonald Road KA1 1RX Kilmarnock | Scotland | British | 78578200001 | |||||||||
| FRASER, Karen Lynn | Director | Top Left 5 Striven Gardens North Kelvinside G20 6DU Glasgow | British | 99523620001 | ||||||||||
| GOODWIN, Kenneth William | Director | 4 Roselea Drive FK2 0TJ Falkirk | British | 52857060001 | ||||||||||
| GRAY, Nelson Campbell | Director | EH25 9QH Roslin Firth House Midlothian United Kingdom | Scotland | British | 155527860001 | |||||||||
| GRIEVE, James Iain Maurice Mcleod, Dr | Director | 31 Redford Avenue EH13 0BX Edinburgh | Scotland | British | 61132770001 | |||||||||
| HAMILTON, David | Director | 11 Bevan Lee Court EH22 2DY Dalkeith Midlothian | Scotland | British | 39428650001 | |||||||||
| HARDY, Ann Margaret | Director | 2 North Larches KY11 4NU Dunfermline Fife | British | 57122020001 | ||||||||||
| LINDSAY, Nigel Bruce | Director | 7/24 Portland Gardens EH6 6NQ Edinburgh Midlothian | British | 85945820001 | ||||||||||
| LOCHHEAD, Gillian | Director | 21 Millhall Crescent DD2 1TN Dundee | British | 57121950001 | ||||||||||
| MCCABE, James | Director | 4 Easterwood Crescent Viewpark G71 5NX Uddingston | Scotland | British | 127181970001 | |||||||||
| MCFADZEAN, Gillian Ethel | Director | 3 Kenilworth Road FK9 4DU Bridge Of Allan Stirlingshire | British | 76406140002 | ||||||||||
| MCGOVERN, Anne | Director | 29 Forth Crescent High Valleyfield KY12 8UL Fife | British | 40078250001 | ||||||||||
| MCLAREN, Gordon | Director | Mayfield Forgandenny PH2 9EQ Perth | Scotland | British | 56469110001 | |||||||||
| MCLEOD, Alan George | Director | 21 Cedar Road Broughty Ferry DD5 3BA Dundee Angus | United Kingdom | British | 5032790001 | |||||||||
| MCNALLY, Teresa | Director | 20 Stanton Avenue FK10 1NE Alloa Clackmannanshire | Scotland | British | 32220500001 | |||||||||
| MCQUAKER, Andrew | Director | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom | Scotland | Scottish | 166848130001 | |||||||||
| MEARNS, Ewan Harry | Director | Flat 1/1 3 Deanston Drive Shawlands G41 3AF Glasgow Lanarkshire | British | 56468930001 | ||||||||||
| MILLARD, James Edward | Director | 2 Redcraig Road East Calder EH53 0QH Livingston West Lothian | British | 47724780001 | ||||||||||
| MURRAY, Norman | Director | 53 Clayknowes Drive EH21 6UW Musselburgh Midlothian | British | 38303460001 | ||||||||||
| PALMER, Julia Anne | Director | 3f2 26 Gardners Crescent EH3 8DF Edinburgh | British | 45572560001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para ESEP LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 07 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene ESEP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 13 nov 2014 Entregado el 22 nov 2014 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 15 mar 2001 Entregado el 27 mar 2001 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0