GLADEMARTIN HOMES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GLADEMARTIN HOMES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC183217 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLADEMARTIN HOMES LIMITED?
- (7011) /
- (7020) /
¿Dónde se encuentra GLADEMARTIN HOMES LIMITED?
Dirección de la sede social | Regency House Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEMARTIN HOMES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
KILMARTIN HOMES (ARBROATH) LTD. | 20 dic 1999 | 20 dic 1999 |
KILMARTIN HOMES LIMITED | 26 jul 1999 | 26 jul 1999 |
FIFE FOOTBALL ZONE LIMITED | 06 may 1998 | 06 may 1998 |
CARETRUE MANAGEMENT LIMITED | 23 feb 1998 | 23 feb 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEMARTIN HOMES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEMARTIN HOMES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Gaffney como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 feb 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 p áginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ el 02 feb 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robin Johnson como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Joanne Elizabeth Massey como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Robin Simon Johnson el 24 nov 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director David Gaffney el 13 nov 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 33 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 14 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLADEMARTIN HOMES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147809090001 | |||||||
FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050002 | ||||
LEWIS, Colin Edward | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MASON, Eddie Roy | Secretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | Company Secretary | 606150007 | |||||
MOTION, Michelle Hunter | Secretario | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
URQUHART, Roderick Macduff | Secretario | The Hall Samuelston EH41 4HG Haddington E Lothian | British | 562500001 | ||||||
OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
BEAZER, Anthony Hadyn | Director | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | Director | 91412650001 | ||||
BETHUNE, Hamish William | Director | Auchenross PH6 2JU Comrie Perthshire | British | Company Director | 1198020003 | |||||
COOPER, James Arthur | Director | 4 Maclean Grove East Kilbride G74 4TJ Glasgow Lanarkshire | British | Company Director | 43500170001 | |||||
DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 35117250001 | ||||
GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Company Director | 75350600002 | ||||
JONES, Steve Keith | Director | 3 Frances Green Beaulieu Park CM1 6EG Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Company Director | 171220150001 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
MCGUINNESS, Neil Stephen | Director | Hazeldean Avenue EH51 0NS Boness 32 West Lothian | United Kingdom | British | Finance Director | 83466350002 | ||||
WOTHERSPOON, Robert John | Director | Glenlyon House Fortingall PH15 2LN Aberfeldy Perthshire | Scotland | British | Chartered Surveyor | 161858620001 | ||||
JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Director designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
¿Tiene GLADEMARTIN HOMES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 14 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 08 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 26 sept 2001 Entregado el 08 oct 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 19 jul 2000 Entregado el 25 jul 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Site at south william street/victoria street, perth. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 01 dic 1999 Entregado el 06 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0