VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE
Visión general
| Nombre de la empresa | VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Convertida/Cerrada |
| Forma jurídica | Convertida o cerrada |
| Número de empresa | SC187421 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
- Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
| Dirección de la sede social | Undercover 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead East Renfrewshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EAST RENFREWSHIRE COUNCIL FOR THE VOLUNTARY SECTOR | 07 jul 1998 | 07 jul 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2015 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluciones Resolutions | 7 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 jul 2015, aucune liste de membres fournie | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Janet Mccormack como director el 14 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Janet Mccormack como secretario el 14 jul 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Donald Macrae Davidson como director el 24 sept 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Janet Mccormack como director el 14 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Janet Mccormack como secretario el 14 jul 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Doctor John Charles Dudgeon como director el 02 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jacqueline Taylor Reid como director el 29 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kenneth Stirling como director el 24 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Douglas Arthur Yates como director el 16 feb 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 jul 2014, aucune liste de membres fournie | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Jacqueline Reid Taylor el 31 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Jacqueline Reid Taylor como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kenneth Greenhill como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lynn Tennent como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 jul 2013, aucune liste de membres fournie | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MEM/ARTS | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ross Christison Mckemmie como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Douglas Arthur Yates como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIDSON, Donald Macrae | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Great Britain | British | 199467480001 | |||||
| DUDGEON, John Charles, Dr | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Scotland | British | 198718260001 | |||||
| KENNEDY, Anne Marie | Director | 50 Levernside Avenue G78 1LW Barrhead East Renfrewshire | Scotland | British | 99342790001 | |||||
| MCDEVITT, Paul Charles | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Scotland | British | 90653930001 | |||||
| MCKEMMIE, Ross Christison | Director | Merrylee Crescent Giffnock G46 6AP Glasgow 10 Scotland | Scotland | British | 3217560001 | |||||
| BIGHAM, Alan Jorge | Secretario | 296 Burnfield Road G43 1EE Glasgow 2/2 United Kingdom | Other | 130616900001 | ||||||
| MCCORMACK, Angela Janet | Secretario | Langcraigs Drive PA2 8JP Paisley 49 Renfrewshire United Kingdom | Scottish | 134480910001 | ||||||
| MINNERY, David John | Secretario | 2 Inglestone Avenue Woodfarm G46 7ES Glasgow Lanarkshire | British | 108814490001 | ||||||
| ARTHUR, Linda Ann | Director | Corrour Road Newlands G43 2DT Glasgow 4 Scotland | Scotland | British | 135510720001 | |||||
| BENNETT, Ann | Director | 98 Aurs Road G78 2NY Barrhead East Renfrewshire | British | 114704940001 | ||||||
| BROWN, Mary Temple | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Scotland | Scottish | 34312250001 | |||||
| BRYAN, Pauline Rita Carmela Catherine | Director | 45 Greenhill Crescent PA3 3BY Linwood Renfrewshire Scotland | British | 62132180001 | ||||||
| CARSWELL, Laura | Director | Kirkton Farm Neilston G78 3HN Glasgow | Scotland | British | 111734220001 | |||||
| CASTRO, Janet | Director | 22 Golf Road Clarkston G76 7PY Glasgow East Renfrewshire | United Kingdom | British | 170148500001 | |||||
| DRENNAN, Olivia Marabel | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Scotland | Scottish | 161182600001 | |||||
| DUNCAN, Catherine | Director | 12 Graham Street Barrhead G78 1ET Glasgow Lanarkshire | British | 99342700001 | ||||||
| FINNIE, Jessie | Director | 93 Main Street Thornliebank G46 7RY Glasgow Lanarkshire | British | 71773990001 | ||||||
| GILLAN, Margaret Irene | Director | 25 Dougray Place Barrhead G78 2RP Glasgow Lanarkshire | British | 99342730001 | ||||||
| GREENHILL, Kenneth Goodman | Director | 11 Cadzow Avenue Giffnock G46 6RD Glasgow | United Kingdom | British | 78887230003 | |||||
| HEALY, Steven William Madden | Director | Hillside Road G78 3ER Neilston 24 East Renfrewshire Scotland | Scotland | British | 139886610001 | |||||
| HERON, Jacqueline Kennedy | Director | 21 Armour Square PA5 8AD Johnstone Renfrewshire | Scotland | British | 125193820002 | |||||
| HUNTER, Walter | Director | 248f Main Street Barrhead G78 1SR Glasgow | British | 59121170001 | ||||||
| KITCHENER, Muriel Gertrude | Director | Flat 3a, 19 Milverton Road Giffnock G46 7JN Glasgow | British | 59121160001 | ||||||
| MCCORMACK, Angela Janet | Director | Langcraigs Drive PA2 8JP Paisley 49 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | Scottish | 134480910001 | |||||
| MCGEADY, Joseph Brian | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Scotland | British | 153160310001 | |||||
| MCGILLIVRAY, Iain Archibald | Director | 20 Berryhill Drive Giffnock G46 7AA Glasgow East Renfrewshire Scotland | British | 62132000001 | ||||||
| MCGUIRE, Catherine | Director | 39 Rufflees Avenue Barrhead G78 1BB Glasgow | British | 59121140001 | ||||||
| MCKEMMIE, Ross Christison | Director | 10 Merrylee Crescent Giffnock G46 6AP Glasgow | Scotland | British | 3217560001 | |||||
| MCKEMMIE, Ross Christison | Director | 10 Merrylee Crescent Giffnock G46 6AP Glasgow | Scotland | British | 3217560001 | |||||
| MCQUADE, Brenda | Director | 45 Levern Crescent G78 2AD Barrhead Renfrewshire | British | 114705080001 | ||||||
| MOORE, Ann Pagan | Director | 5 The Loaning G46 6SE Glasgow Strathclyde | Scotland | British | 82633870001 | |||||
| MOORE, Hugh Alexander Mathison | Director | 11 Carleton Drive Giffnock G46 6AJ East Renfrewshire | British | 82205670001 | ||||||
| REID, Jacqueline Taylor | Director | Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NW Glasgow 21 Scotland | Scotland | British | 186436920002 | |||||
| REID, Jaqueline | Director | 21 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NW Glasgow Lanarkshire | British | 123618140001 | ||||||
| ROBERTSON, Lisa-Marie | Director | 56 Kelburn Street G78 1LR Barrhead Undercover East Renfrewshire | Scotland | Scottish | 153167300001 |
¿Tiene VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 10 mar 2006 Entregado el 18 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Tenants interest in lease over unit 8 westbourne centre, kelburn street, barrhead and area of ground outside REN118897 REN118898. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 28 oct 2005 Entregado el 16 nov 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The lease of the subjects forming unit 8 of the westbourne centre, kelburn street, barrhead being the subjects on the ground floor and lower ground floor (title numbers REN112124 and REN3350) and the lease of that area of ground outside unit 8, westbourne centre, kelburn street, barrhead (title number REN3350). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0