CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC187448 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Glenn Sinclair Pearce como director el 19 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Francesca Kavanagh como director el 12 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Modification des détails de Eri Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del secretario Infrastructure Managers Limited el 17 feb 2025 | 1 páginas | CH04 | ||
Cese del nombramiento de Kirsty O'brien como director el 22 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Ivor Cavill el 10 jun 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Carl Harvey Dix como director el 24 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de John Wrinn como director el 24 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del secretario Infrastructure Managers Limited el 15 dic 2023 | 1 páginas | CH04 | ||
Cambio de datos del director Mr John Wrinn el 13 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN United Kingdom a C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN el 12 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF Scotland a Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN el 12 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr John Wrinn como director el 19 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Matthew James Edwards como director el 19 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Miss Kirsty O'brien el 06 may 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secretario corporativo | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| CAVILL, John Ivor | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 152521640005 | |||||||||
| DIX, Carl Harvey | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 305019190001 | |||||||||
| KAVANAGH, Francesca | Director | Cobalt Square 83-85 Hagley Road B16 8QG Birmingham 9th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 332385150001 | |||||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 Exchange Crescent Scotland |
| 900003420001 | ||||||||||
| ARCHBOLD, Michael | Director | Copper Beech 5 Homewood GU6 7HS Cranleigh Surrey | British | 41071010002 | ||||||||||
| CAMPBELL, Alastair John | Director | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 138735100001 | |||||||||
| CARVALHO, Guilherme | Director | E14 4BB Canary Wharf 1 Churchill Place London | Brazilian | 138468870001 | ||||||||||
| CASHMORE, James | Director | 4 College Farm Close Oddington OX5 2RL Kidlington Oxfordshire | British | 65973720001 | ||||||||||
| COHEN, James Lionel | Director | 60 Ormonde Terrace NW8 7LR London | British | 62128810002 | ||||||||||
| D'ALONZO, Fabio | Director | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Scotland | United Kingdom | Italian | 151189940001 | |||||||||
| EDWARDS, Matthew James | Director | Palace Street SW1E 5JD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | 222288660001 | |||||||||
| FALERO, Louis Javier | Director | Palace Street SW1E 5JD London 16 England | England | British | 163057440001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Director | Floor, 350 Euston Road Regent's Place NW1 3AX London 6th United Kingdom | United Kingdom | British | 149538970001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Director | Eden Park Road SK8 6RG Cheadle Hulme 7 Cheshire | England | British | 170508700001 | |||||||||
| HOPE, John Alexander | Director | Eildon, 17 Craigielaw Park Aberlady EH32 0PR Longniddry East Lothian | United Kingdom | British | 71318590003 | |||||||||
| LEWIS, David John | Director | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | England | British | 136129100001 | |||||||||
| MADDICK, Kevin John | Director | 16 Ringford Road Wandsworth SW18 1RS London | United Kingdom | British | 94650970001 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Director | 59 Sarsfield Road SW12 8HR London | British | 116580030001 | ||||||||||
| MILLAR, Jeremy Westgarth | Director | Barberry House The Row Wellington HR4 8AP Hereford | United Kingdom | British | 94746150001 | |||||||||
| O'BRIEN, Kirsty | Director | Level 3 (South) 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London Equitix Limited United Kingdom | Scotland | British | 191923490001 | |||||||||
| PEARCE, Glenn Sinclair | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor South Building United Kingdom | Scotland | British | 176131560002 | |||||||||
| POPE, Anthony | Director | 14 Merlin Park FK14 7BZ Dollar Clackmannanshire | British | 50323440001 | ||||||||||
| PRITCHARD, Jamie | Director | Floor, 350 Euston Road Regent's Place NW1 3AX London 6th United Kingdom | United Kingdom | British | 180899790001 | |||||||||
| RABIN, Anthony Leon Philip | Director | Fourth Floor 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | British | 10280970002 | ||||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Director | 57 Kettilstoun Mains EH49 6SH Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||
| RYAN, Michael Joseph | Director | Central Building 3 Matthew Parker Street SW1H 9NE London Apartment 42, | United Kingdom | Irish | 77999320003 | |||||||||
| RYLATT, Ian Kenneth | Director | 127 Park Road W4 3EX London | England | British | 84053160001 | |||||||||
| SHELDRAKE, Peter John | Director | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Scotland | England | British | 164986530026 | |||||||||
| SMITH, Michael William | Director | 17 Hippodrome Mews W11 4NN London | British | 59089770002 | ||||||||||
| SPENCER, Christopher Loraine | Director | 143 Shooters Hill Road Blackheath SE3 8UQ London | United Kingdom | British | 111123420001 | |||||||||
| SWARBRICK, David James | Director | Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 | United Kingdom | British | 135802540001 | |||||||||
| THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor South Building United Kingdom | United Kingdom | British | 250018940001 | |||||||||
| THOMSON, Lisa Marie | Director | Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 | United Kingdom | British | 181210560001 | |||||||||
| THORNTON, Jeffrey Michael | Director | 108 March Road EH4 3SX Edinburgh | United Kingdom | British | 19241770002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CONSORT HEALTHCARE (EDINBURGH ROYAL INFIRMARY) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitix Infrastructure 3 Limited | 06 abr 2016 | 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Eri Holdings Limited | 06 abr 2016 | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0