VPI POWER LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | VPI POWER LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC189124 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VPI POWER LIMITED?
- Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
¿Dónde se encuentra VPI POWER LIMITED?
| Dirección de la sede social | Building 1 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VPI POWER LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DRAX GENERATION ENTERPRISE LIMITED | 09 ene 2019 | 09 ene 2019 |
| SCOTTISHPOWER GENERATION LIMITED | 21 mar 2003 | 21 mar 2003 |
| SCOTTISH POWER GENERATION PLC | 31 oct 2002 | 31 oct 2002 |
| SCOTTISHPOWER GENERATION LIMITED | 14 dic 1998 | 14 dic 1998 |
| RANDOTTE (NO. 461) LIMITED | 07 sept 1998 | 07 sept 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VPI POWER LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para VPI POWER LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 ene 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 ene 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VPI POWER LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de la carga SC1891240047, creada el 21 nov 2025 | 58 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC1891240045 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC1891240044 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC1891240046 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 73 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Essex como secretario el 11 mar 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Joshua Kyle Solomon como director el 31 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam White como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Lee Stuart Warren como director el 20 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Brignall como director el 20 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 9 Building 1 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland a Building 1 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY el 08 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 20 Castle Terrace 2nd Floor North, Saltire Court Edinburgh EH1 2EN Scotland a 9 Building 1 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY el 08 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Registro de la carga SC1891240046, creada el 13 feb 2023 | 66 páginas | MR01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam White como director el 16 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jorge Pikunic como director el 16 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Robert Hale como director el 16 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 41 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de VPI POWER LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIKUNIC, Jorge | Director | 160 Victoria Street SW1E 5LB London Nova South, 4th Floor England | England | British | 303512780001 | |||||
| SOLOMON, Joshua Kyle | Director | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Building 1 Scotland | England | British | 330907360001 | |||||
| WARREN, Lee Stuart | Director | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Building 1 Scotland | England | British | 149619990001 | |||||
| DAVIES, Michael Howard | Secretario | 1 Atlantic Quay, Robertson Street G2 8SP Glasgow Scottish Power Ltd | British | 157786830001 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Secretario | 197 Queen Victoria Drive Scotstounhill G14 9BP Glasgow | British | 52720790003 | ||||||
| ESSEX, Elizabeth Jane | Secretario | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Building 1 Scotland | 279126950001 | |||||||
| GLADDEN, Brett | Secretario | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 Scotland | 256217080001 | |||||||
| GREGG, Rhona | Secretario | 25 Lammermuir Wynd ML9 1UT Larkhall Lanarkshire | British | 111591600001 | ||||||
| MCCALLUM, David | Secretario | Selby North Yorkshire Drax Power Station Yo8 8ph England | 253924960001 | |||||||
| MCPHERSON, Donald James | Secretario | 14 Braid Drive Cardross G82 5QD Dumbarton Dunbartonshire | British | 40519810004 | ||||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Secretario designado | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Secretario | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| ORR, Alistair | Secretario | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | 194090520001 | |||||||
| ROSS, Marie Isobel | Secretario | 51 Killermont Road Bearsden G61 2JF Glasgow | British | 42057170004 | ||||||
| BERRY, Charles Andrew | Director | 5 Grange Road Bearsden G61 3PL Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 109780690001 | |||||
| BRIGNALL, David, Mr. | Director | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Building 1 Scotland | England | British | 279126920002 | |||||
| BRYCE, Alan Alexander | Director | Flat 1l 15 Kelburn Court KA30 8HN Largs Ayrshire | Scotland | British | 81354840001 | |||||
| CAMPBELL, John Alexander | Director | 1 Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow Scottish Power Ltd | Scotland | British | 148798390001 | |||||
| CHALMERS WHITE, Heather | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Scotland | British | 255610960001 | |||||
| CLITHEROE, Neil David | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Scotland | British | 141151620002 | |||||
| FINLAY, Hugh Ogg | Director | Scottish Power 1 Atlantic Quay G2 8SP Robertson Street Glasgow | England | British | 88610970001 | |||||
| FORTIS PITA, Oscar | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Spanish | Spanish | 159162440002 | |||||
| GARDINER, Dwight Daniel Willard | Director | Selby Y08 8PH North Yorkshire Drax Power Station England | United Kingdom | British,American | 76076980002 | |||||
| GOLLAND, Eric Stanley | Director | Little Porton 201 Old Greenock Road PA7 5NT Bishopton Renfrewshire | British | 92874420001 | ||||||
| GRANT, Robin Forsyth | Director | 18 Manse Crescent FK7 9AJ Stirling | British | 77505530002 | ||||||
| HALE, Simon Robert | Director | Castle Terrace 2nd Floor North, Saltire Court EH1 2EN Edinburgh 20 Scotland | England | British | 180422590002 | |||||
| KOSS, Andrew Robert | Director | Selby YO8 8PH North Yorkshire Drax Power Station England | England | English | 157160710002 | |||||
| MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Director designado | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
| MITCHELL, Frank | Director | 16 Dunedin Drive Hairmyres G75 8QQ East Kilbride Lanarkshire | Scotland | British | 120942640001 | |||||
| MORRISON, David Neil | Director | 10 Sydenham Road G12 9NP Glasgow | British | 45144330001 | ||||||
| REYNARD, Charles William | Director | East Barn YO62 5XZ Oswaldkirk Nr York North Yorkshire | United Kingdom | British | 149042880001 | |||||
| RUSSELL, Ian Simon Macgregor | Director | 73 Braid Avenue EH10 6ED Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 38783050003 | |||||
| SKELTON, Andrew Keith | Director | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 Scotland | United Kingdom | British | 172965530001 | |||||
| VOWLES, Kenneth Leslie, Professor | Director | Coppice Gate, Plealey Contesbury SY5 0UY Shrewsbury | United Kingdom | British | 33865740001 | |||||
| WHITE, Adam | Director | 160 Victoria Street SW1E 5LB London Nova South, 4th Floor England | England | British | 303512810001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de VPI POWER LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vpi Generation Limited | 31 ene 2021 | 160 Victoria Street 4th Floor SW1E 5LB London Nova South England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Drax Smart Generation Holdco Limited | 31 dic 2018 | Selby North Yorkshire Drax Power Station Yo8 8ph England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Scottish Power Generation Holdings Limited | 06 abr 2016 | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0