DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED

DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC192465
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    50 Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NINEWELLS HEALTHCARE SERVICES LIMITED17 mar 199917 mar 1999
    LOTHIAN FIFTY (557) LIMITED11 ene 199911 ene 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el28 mar 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 ene 2027
    Próxima declaración de confirmación vence25 ene 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 ene 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2024 au 30 dic 2024

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Neil Edward Kay como director el 31 ago 2025

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Ms Katherine Selina Bairstow el 29 abr 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Katherine Selina Bairstow como director el 29 abr 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023

    25 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Bean como director el 09 ago 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Carlo Alloni como director el 04 sept 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Neil Edward Kay como director el 02 oct 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Perkins como director el 02 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Perkins como secretario el 02 oct 2023

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022

    25 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Paul Bean como director el 16 may 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    26 páginasAA

    Cese del nombramiento de David John Smith como director el 13 ene 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    27 páginasAA

    Nombramiento de Mr Timothy John Cooper como director el 15 mar 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Singleton como director el 15 mar 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019

    23 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stephen Perkins el 14 sept 2020

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALLONI, Carlo
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandItalian320201170001
    BAIRSTOW, Katharine Selina
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish336252530002
    COOPER, Timothy John
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish15896470002
    BUTTERY, Alison Tracey
    9 Cornish Court
    16 Bridlington Road
    N9 7RS London
    Secretario
    9 Cornish Court
    16 Bridlington Road
    N9 7RS London
    British61671200001
    CHATER, Andrew John Gordon
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    Secretario
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    197124940001
    LUCAS, Keith
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Ruthvenfield Road
    Secretario
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Ruthvenfield Road
    British154110290001
    MONAGHAN, Yvonne May
    Ruthvenfield Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Secretario
    Ruthvenfield Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    British153922640001
    PERKINS, Stephen
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Secretario
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    275311200001
    RUDZINSKI, Alexander Peter Marek
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Secretario
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    214323330001
    WILTON, David Charles
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Secretario
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    British180907240001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Secretario corporativo
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    BEAN, Paul
    1 Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Peat House
    England
    Director
    1 Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Peat House
    England
    EnglandBritish297685780002
    BIRCH, Alan Edward
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    Director
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish90700330001
    CHATER, Andrew John Gordon
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    Director
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    United KingdomBritish135879330001
    CUMMINGS, Shaun Francis
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Ruthvenfield Road
    Director
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Ruthvenfield Road
    United KingdomBritish46340470001
    GARDINER, Patrick Hugh
    Greystones
    Cornsland
    CM14 4JL Brentwood
    Essex
    Director
    Greystones
    Cornsland
    CM14 4JL Brentwood
    Essex
    British63883470001
    GORDON, Ray
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Director
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    British102379260001
    HALL, Peter William
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    Director
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    United KingdomBritish128359350001
    HOLT, Martin John
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish55099500002
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Director
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KAY, Neil Edward
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish171995900001
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Director
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritish146249130001
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Director
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    LUCAS, Barry
    40 Grovelands Road
    Palmers Green
    N13 4RH London
    Director
    40 Grovelands Road
    Palmers Green
    N13 4RH London
    British6709900001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Director
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    MONAGHAN, Yvonne May
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Ruthvenfield Road
    Director
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Ruthvenfield Road
    EnglandBritish7934540003
    MORRIS, Timothy James
    Ruthvenfield Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Director
    Ruthvenfield Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    EnglandBritish126969480002
    OGLE, Paul Derek
    Ruthvenfield Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Scotland
    Director
    Ruthvenfield Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3SW Perth
    Scotland
    United KingdomBritish73043500003
    PERKINS, Stephen
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish275312610001
    RUDZINSKI, Alexander Peter Marek
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish209356720001
    SINGLETON, Richard
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish204509980001
    SMITH, David John
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Director
    Lothian Road
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish209356620001
    SUTTON, Andrew John
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    Director
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    United KingdomBritish110729740001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DUNDEE HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bell Rock Workplace Management Ltd
    Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Peat House
    England
    06 abr 2016
    Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Peat House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0